An Act to Amend the Business Corporations Act. Loi modifiant la Loi sur les corporations commerciales CHAPTER 50 CHAPITRE 50
|
|
- Auguste Brousseau
- il y a 5 ans
- Total affichages :
Transcription
1 2014 CHAPTER 50 CHAPITRE 50 An Act to Amend the Business Corporations Act Loi modifiant la Loi sur les corporations commerciales Assented to May 21, 2014 Sanctionnée le 21 mai 2014 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as follows: 1 Subsection 4(1) of the Business Corporations Act, chapter B-9.1 of the Acts of New Brunswick, 1981, is amended in the portion preceding paragraph (a) by striking out follow the prescribed form and substituting be in the form Sa Majesté, sur l avis et avec le consentement de l Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : 1 Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1981, est modifié au passage qui précède l alinéa a) par la suppression de «en la forme prescrite» et son remplacement par «au moyen de la formule que fournit le directeur». 2 Section 17 of the Act is amended 2 L article 17 de la Loi est modifié (a) in subsection (2) by striking out in prescribed form shall be sent to the Director and substituting shall be sent to the Director in the form provided by the Director ; (b) in subsection (4) by striking out in prescribed by the Director. 3 Subsection 26(4) of the Act is amended by striking 4 Subsection 64(1) of the Act is repealed and the following a) au paragraphe (2), par la suppression de «en la forme prescrite doit être envoyé au Directeur, accompagné des» et son remplacement par «doit être envoyé au directeur au moyen de la formule qu il fournit, ensemble les»; b) au paragraphe (4), par la suppression de «en la de la formule qu il fournit». 3 Le paragraphe 26(4) de la Loi est modifié par la suppression de «en la forme prescrite» et son remplacement par «au moyen de la formule qu il fournit». 4 Le paragraphe 64(1) de la Loi est abrogé et remplacé 1
2 2014, ch. 50 Loi modifiant la Loi sur les corporations commerciales 64(1) At the time of sending articles of incorporation, the incorporators shall send to the Director a notice of directors in the form provided by the Director and the Director shall file the notice. 5 Subsection 71(1) of the Act is amended by striking 6 Subsection 116(1) of the Act is amended by striking 7 Subsection 119(2) of the Act is repealed and the following 119(2) Restated articles of incorporation shall be sent to the Director in the form provided by the Director. 8 Subsection 124(1) of the Act is repealed and the following 124(1) Subject to subsection 122(6), after an amalgamation has been adopted under section 122 or approved under section 123, articles of amalgamation shall be sent to the Director in the form provided by the Director together with the documents required by sections 17 and Subsection 126(2) of the Act is repealed and the following 126(2) Articles of continuance shall be sent to the Director in the form provided by the Director together with the documents prescribed by sections 17 and Subsection 129(1) of the Act is amended by striking 11 Subsection 132(4) of the Act is repealed and the following 132(4) After a reorganization has been made, articles of reorganization shall be sent to the Director in the form provided by the Director together with the documents required by sections 17 and 71, if applicable. 64(1) Les fondateurs doivent envoyer au Directeur, ensemble les statuts constitutifs, une liste des administrateurs au moyen de la formule qu il fournit, lequel l enregistre. 5 Le paragraphe 71(1) de la Loi est modifié par la suppression de «en la forme prescrite le Directeur qui doit enregistrer cet avis» et son remplacement par «le Directeur au moyen de la formule qu il fournit, lequel l enregistre». 6 Le paragraphe 116(1) de la Loi est modifié par la suppression de «en la forme prescrite au Directeur» et son remplacement par «au Directeur au moyen de la formule qu il fournit». 7 Le paragraphe 119(2) de la Loi est abrogé et remplacé 119(2) Les statuts mis à jour doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu il fournit. 8 Le paragraphe 124(1) de la Loi est abrogé et remplacé 124(1) Sous réserve du paragraphe 122(6), une fois la fusion adoptée en vertu de l article 122 ou approuvée en vertu de l article 123, les statuts de fusion doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu il fournit, ensemble tous les documents exigés aux articles 17 et Le paragraphe 126(2) de la Loi est abrogé et remplacé 126(2) Les statuts de prorogation doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu il fournit, ensemble les autres documents exigés aux articles 17 et Le paragraphe 129(1) de la Loi est modifié par la suppression de «en la forme prescrite, ainsi que, le cas échéant, les» et son remplacement par «au moyen de la formule qu il fournit, ensemble, le cas échéant, les». 11 Le paragraphe 132(4) de la Loi est abrogé et remplacé 132(4) Une fois qu il a été procédé à la réorganisation, les statuts de réorganisation doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu il fournit, ensemble, le cas échéant, les documents exigés aux articles 17 et 71. 2
3 An Act to Amend the Business Corporations Act 2014, c Subsection 136(3) of the Act is repealed and the following 136(3) Articles of revival shall be sent to the Director in the form provided by the Director. 13 Subsection 137(4) of the Act is repealed and the following 137(4) Articles of dissolution shall be sent to the Director in the form provided by the Director. 12 Le paragraphe 136(3) de la Loi est abrogé et remplacé 136(3) Les statuts de reconstitution doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu il fournit. 13 Le paragraphe 137(4) de la Loi est abrogé et remplacé 137(4) Les statuts de dissolution doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu il fournit. 14 Section 138 of the Act is amended 14 L article 138 de la Loi est modifié (a) by repealing subsection (4) and substituting the 138(4) A statement of intent to dissolve shall be sent to the Director in the form provided by the Director. (b) in subsection (10) by striking out in prescribed by the Director ; (c) by repealing subsection (14) and substituting the 138(14) Articles of dissolution shall be sent to the Director in the form provided by the Director. a) par l abrogation du paragraphe (4) et son remplacement 138(4) Une déclaration d intention de dissolution doit être envoyée au Directeur au moyen de la formule qu il fournit. b) au paragraphe (10), par la suppression de «en la de la formule qu il fournit»; c) par l abrogation du paragraphe (14) et son remplacement 138(14) Les statuts de dissolution doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu il fournit. 15 Subsection 140(4) of the Act is amended 15 Le paragraphe 140(4) de la Loi est modifié (a) in paragraph (a) by striking out in prescribed form ; (b) in paragraph (b) by striking out in prescribed form. 16 The Act is amended by adding after section 185 the 185.1(1) The Director may prescribe the form and content of the forms that are required to be sent to the Director under this Act, including prescribing whether a signature is required and any additional requirements respecting signatures (2) The Director may, in the forms referred to in subsection (1), request personal information either directly from an individual to which the information relates, or indirectly, from any other person authorized to complete the form. a) à l alinéa a), par la suppression de «en la forme prescrite,»; b) à l alinéa b), par la suppression de «en la forme prescrite,». 16 La Loi est modifiée par l adjonction de ce qui suit après l article 185 : 185.1(1) Le Directeur peut préciser le libellé et la teneur des formules devant être déposées auprès de lui en vertu de la présente loi, notamment en déterminant si elles doivent être signées et en établissant des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature (2) Le Directeur peut, dans les formules visées au paragraphe (1), recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement de la personne physique concernée ou par l entremise de toute autre personne autorisée à remplir la formule. 3
4 2014, ch. 50 Loi modifiant la Loi sur les corporations commerciales 185.1(3) The Regulations Act does not apply to forms or requirements referred to in subsection (1) (4) If there is a conflict or an inconsistency between a form referred to in subsection (1) and this Act or any regulation made under this Act, this Act or the regulation made under this Act prevails. 17 Subsection 187(1) of the Act is amended by striking out in the prescribed form and substituting in the form 18 Section 193 of the Act is amended by repealing paragraph (a) of the definition attorney for service or attorney and substituting the (a) consents, in the form provided by the Director, to act as an extra-provincial corporation s attorney for service, and 185.1(3) La Loi sur les règlements ne s applique ni aux formules ni aux exigences visées au paragraphe (1) (4) La présente loi et ses règlements l emportent sur toute formule incompatible visée au paragraphe (1). 17 Le paragraphe 187(1) de la Loi est modifié par la suppression de «, en la forme prescrite, et le Directeur doit le déposer» et son remplacement par «au moyen de la formule que fournit le Directeur, lequel doit le déposer». 18 L article 193 de la Loi est modifié par l abrogation de l alinéa a) de la définition «procureur pour fin de signification» ou «procureur» et son remplacement par ce qui suit : a) consent, au moyen de la formule que fournit le Directeur, à agir à titre de procureur pour fin de signification de la corporation extraprovinciale, et 19 Subsection 194(4) of the Act is amended 19 Le paragraphe 194(4) de la Loi est modifié (a) by repealing paragraph (a) and substituting the (a) send to the Director the appointment of its attorney for service in the form provided by the Director, and (b) in paragraph (b) by striking out in the prescribed 20 Subsection 196(4) of the Act is amended in the portion following paragraph (b) by striking out in the prescribed by the Director. a) par l abrogation de l alinéa a) et son remplacement a) envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu il fournit, la nomination de son procureur pour fin de signification, et b) à l alinéa b), par la suppression de «en la forme prescrite» et son remplacement par «au moyen de la formule qu il fournit». 20 Le paragraphe 196(4) de la Loi est modifié au passage qui suit l alinéa b), par la suppression de «en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur» et son remplacement par «en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu il fournit». 21 Section 197 of the Act is amended 21 L article 197 de la Loi est modifié (a) in subsection (1) by striking out in the prescribed by the Director ; (b) in paragraph (2)(a) by striking out in prescribed a) au paragraphe (1), par la suppression de «en la de la formule qu il fournit»; b) à l alinéa (2)a), par la suppression «en la forme prescrite» et son remplacement par «au moyen de la formule que fournit le Directeur». 4
5 An Act to Amend the Business Corporations Act 2014, c Subsection 200(1) of the Act is amended by striking out the portion preceding paragraph (a) and substituting the 200(1) On receipt of the statement referred to in section 197, any other documents required by that section and the prescribed fee for an application for registration from an extra-provincial corporation, the Director shall, unless otherwise specifically provided, 22 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié par l abrogation du passage qui précède l alinéa a) et son remplacement 200(1) Sur réception de la déclaration visée à l article 197, des autres documents qu exige cet article et des droits prescrits pour une demande d enregistrement que présente une corporation extraprovinciale, le Directeur doit, sauf disposition expresse contraire, 23 Section 201 of the Act is amended 23 L article 201 de la Loi est modifié (a) by repealing subsection (3) and substituting the 201(3) On receipt of an application in a form provided by the Director accompanied by the prescribed reinstatement fee, in addition to any other fees, notices and documents required to be sent to the Director, the Director may reinstate the registration of an extra-provincial corporation that was cancelled under paragraph (1)(a). (b) in subsection (3.1) by striking out in the prescribed form. a) par l abrogation du paragraphe (3) et son remplacement 201(3) Sur réception de la demande présentée au moyen de la formule qu il fournit, ensemble les droits de rétablissement prescrits ainsi que tous autres droits, avis et documents qui doivent lui être envoyés, le Directeur peut rétablir l enregistrement d une corporation extraprovinciale qui a été annulé en vertu de l alinéa (1)a). b) au paragraphe (3.1), par la suppression de «en la forme prescrite». 24 Section 203 of the Act is amended 24 L article 203 de la Loi est modifié (a) in subsection (1) by striking out in the prescribed (b) by repealing subsection (3) and substituting the 203(3) An attorney shall send to the Director without delay a notice of any change of the attorney s address in the form provided by the Director and the Director shall file the notice. a) au paragraphe (1), par la suppression de «au Directeur une nomination en la forme prescrite» et son remplacement par «au Directeur, au moyen de la formule qu il fournit, une nomination»; b) par l abrogation du paragraphe (3) et son remplacement 203(3) Tout procureur doit envoyer sans délai un avis de son changement d adresse au Directeur au moyen de la formule qu il fournit, lequel doit le déposer. 25 Section 206 of the Act is amended 25 L article 206 de la Loi est modifié (a) in the portion preceding paragraph (1)(a) by adding, in the form provided by the Director after Director ; (b) in subsection (3) by striking out in the prescribed form. 26 Subsection 207(1) of the Act is amended by striking out in the prescribed form and substituting in the form a) au passage qui précède l alinéa (1)a), par l adjonction après «Directeur» de «, au moyen de la formule qu il fournit»; b) au paragraphe (3), par la suppression de «en la forme prescrite». 26 Le paragraphe 207(1) de la Loi est modifié par la suppression de «en la forme prescrite» et son remplacement par «au moyen de la formule qu il fournit». 5
6 2014, ch. 50 Loi modifiant la Loi sur les corporations commerciales 27 Section 209 of the Act is amended 27 L article 209 de la Loi est modifié (a) by repealing subsection (1) and substituting the 209(1) A registered extra-provincial corporation shall, annually, on or before the last day of the month following the anniversary month, send to the Director an annual return, in the form provided by the Director, signed by a director or an officer of the extra-provincial corporation and the Director shall file it. (b) in subsection (2) by striking out in prescribed by the Director ; (c) in subsection (3) by striking out in the prescribed 28 Section of the Act is amended in the portion following paragraph (b) by adding in the form provided by the Director after notice of such issuance. 29 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation. a) par l abrogation du paragraphe (1) et son remplacement 209(1) Toute corporation extraprovinciale enregistrée doit annuellement, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire, envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu il fournit, un rapport annuel signé par l un de ses administrateurs ou dirigeants, lequel doit le déposer. b) au paragraphe (2), par la suppression de «en la de la formule que fournit le Directeur»; c) au paragraphe (3), par la suppression de «en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur» et son remplacement par «en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu il fournit». 28 L article de la Loi est modifié au passage qui suit l alinéa b) par l adjonction de «au moyen de la formule qu il fournit» après «avis de cette délivrance». 29 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation. QUEEN S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/tous droits réservés 6
Bill 69 Projet de loi 69
1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 69 Projet de loi 69 An Act to amend the Business Corporations Act and the
Plus en détailAn Act to Amend the Tobacco Sales Act. Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac CHAPTER 46 CHAPITRE 46
2015 CHAPTER 46 CHAPITRE 46 An Act to Amend the Tobacco Sales Act Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac Assented to June 5, 2015 Sanctionnée le 5 juin 2015 Her Majesty, by and with the advice and
Plus en détailCheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to
Plus en détailPROJET DE LOI. An Act Respecting the Revised Statutes, 2014. Loi concernant les Lois révisées de 2014
1st Session, 58th Legislature New Brunswick 63-64 Elizabeth II, 2014-2015 1 re session, 58 e législature Nouveau-Brunswick 63-64 Elizabeth II, 2014-2015 BILL PROJET DE LOI 12 12 An Act Respecting the Revised
Plus en détailPROJET DE LOI. An Act to Amend the Employment Standards Act. Loi modifiant la Loi sur les normes d emploi
2nd Session, 57th Legislature New Brunswick 60-61 Elizabeth II, 2011-2012 2 e session, 57 e législature Nouveau-Brunswick 60-61 Elizabeth II, 2011-2012 BILL PROJET DE LOI 7 7 An Act to Amend the Employment
Plus en détailSupport Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques
Plus en détailFirst Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION First Nations Assessment Inspection Regulations Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations SOR/2007-242 DORS/2007-242 Current to September
Plus en détailC H A P T E R 4 C H A P I T R E 4. (Assented to June 16, 2011) (Date de sanction : 16 juin 2011)
C H A P T E R 4 C H A P I T R E 4 THE PRESCRIPTION DRUGS COST ASSISTANCE AMENDMENT ACT (PRESCRIPTION DRUG MONITORING AND MISCELLANEOUS AMENDMENTS) LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS
Plus en détailOrder Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act Décret liant certains mandataires
Plus en détailLoi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,
Plus en détailCredit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44
Plus en détailRèglement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Bill of Rights Examination Regulations Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits C.R.C., c. 394 C.R.C., ch. 394 Current
Plus en détailInput Tax Credit Information (GST/HST) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/ TVH) SOR/91-45 DORS/91-45
Plus en détailCONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95
CONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L ADOPTION SELON LES
Plus en détailMaterial Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Material Banking Group Percentage Regulations Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) SOR/2008-163 DORS/2008-163 Current to August 30, 2015 À jour
Plus en détailShips Elevator Regulations. Règlement sur les ascenseurs de navires CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Ships Elevator Regulations Règlement sur les ascenseurs de navires C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482 Current to September 10, 2015 À jour au 10 septembre 2015 Last amended
Plus en détailLoi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement. Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement S.C. 1987, c. 27 L.C. 1987,
Plus en détailBill 163 Projet de loi 163
2ND SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 60 ELIZABETH II, 2011 2 e SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 60 ELIZABETH II, 2011 Bill 163 Projet de loi 163 (Chapter 8 Statutes of Ontario, 2011) (Chapitre 8 Lois
Plus en détailInterest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Interest Rate for Customs Purposes Regulations Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes SOR/86-1121 DORS/86-1121 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août
Plus en détailBorrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurances multirisques et des sociétés d assurance
Plus en détailGeneral Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel SOR/95-43 DORS/95-43 Current to June
Plus en détailAPPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder
Page 1 APPENDIX 2 Provisions to be included in the contract between the Provider and the Obligations and rights of the Applicant / Holder Holder 1. The Applicant or Licensee acknowledges that it has read
Plus en détailBill 204 Projet de loi 204
3RD SESSION, 37TH LEGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 3 e SESSION, 37 e LÉGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 Bill 204 Projet de loi 204 An Act to amend the Ontario Energy Board Act, 1998 to
Plus en détailDisclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de
Plus en détailBill 12 Projet de loi 12
1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 Bill 12 Projet de loi 12 An Act to amend the Employment Standards Act, 2000 with
Plus en détailde stabilisation financière
CHAPTER 108 CHAPITRE 108 Fiscal Stabilization Fund Act Loi sur le Fonds de stabilisation financière Table of Contents 1 Definitions eligible securities valeurs admissibles Fund Fonds Minister ministre
Plus en détailDisclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de compte
Plus en détailRULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5
RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative
Plus en détailName Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations Règlement sur l utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu une banque ou société
Plus en détailRèglement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits C.R.C., c. 320 C.R.C., ch. 320 Current
Plus en détailPART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11
PART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11 Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest 2010-11-30 TABLE OF CONTENTS / SI: Statutory Instrument / R: Regulation / TABLE
Plus en détailAir Transportation Tax Order, 1995. Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Air Transportation Tax Order, 1995 Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien SOR/95-206 DORS/95-206 Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015 Published by
Plus en détailBILL 203 PROJET DE LOI 203
Bill 203 Private Member's Bill Projet de loi 203 Projet de loi d'un député 4 th Session, 40 th Legislature, Manitoba, 63 Elizabeth II, 2014 4 e session, 40 e législature, Manitoba, 63 Elizabeth II, 2014
Plus en détailAMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32
THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the
Plus en détailShort-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Short-term Pooled Investment Fund Regulations Règlement sur le fonds commun de placement à court terme SOR/2006-245 DORS/2006-245 Current to September 27, 2015 À jour
Plus en détailImport Allocation Regulations. Règlement sur les autorisations d importation CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Import Allocation Regulations Règlement sur les autorisations d importation SOR/95-36 DORS/95-36 Current to May 17, 2011 À jour au 1 er 17 mai 2011 Published by the Minister
Plus en détailFiled December 22, 2000
NEW BRUNSWICK REGULATION 2000-64 under the SPECIAL PAYMENT TO CERTAIN DEPENDENT SPOUSES OF DECEASED WORKERS ACT (O.C. 2000-604) Regulation Outline Filed December 22, 2000 Citation..........................................
Plus en détailCalculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Calculation of Interest Regulations Règlement sur le calcul des intérêts SOR/87-631 DORS/87-631 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published by the Minister
Plus en détailOrdonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Infant or Person of Unsound Mind Payment Order Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit C.R.C., c. 1600 C.R.C., ch. 1600 Current
Plus en détailBill 2 Projet de loi 2
1ST SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 56 ELIZABETH II, 2007 1 re SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 56 ELIZABETH II, 2007 Bill 2 Projet de loi 2 (Chapter 16 Statutes of Ontario, 2007) (Chapitre 16 Lois
Plus en détailBILL C-452 PROJET DE LOI C-452 C-452 C-452 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
C-452 C-452 First Session, Forty-first Parliament, Première session, quarante et unième législature, HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA BILL C-452 PROJET DE LOI C-452 An Act to amend
Plus en détailRailway Operating Certificate Regulations. Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Railway Operating Certificate Regulations Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer SOR/2014-258 DORS/2014-258 Current to September 10, 2015 À jour
Plus en détailAvis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur. Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice Avis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur C.R.C., c. 41 C.R.C., ch.
Plus en détailRèglement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation
THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel
Plus en détailLOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT
ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION REGULATIONS R-085-95 In force September 30, 1995 LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES
Plus en détailOttawa,, 2009 Ottawa, le 2009
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 479 à 485 a, 488 b et 1021 c de la Loi sur les sociétés d assurances d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur
Plus en détailLife Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Life Companies Borrowing Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie SOR/92-277 DORS/92-277 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published
Plus en détailBILL 13 PROJET DE LOI 13. certains droits relatifs à l approvisionnement en bois et à l aménagement forestier
1st Session, 56th 58th Legislature New Brunswick 63-6456 Elizabeth II, II, 2014-2015 2007 1 re session, 56 58 e législature Nouveau-Brunswick 63-64 56 Elizabeth II, II, 2014-2015 2007 BILL 13 PROJET DE
Plus en détailPROJET DE LOI 15 BILL 15. 1st Session, 56th 58th Legislature New Brunswick 63-6456 Elizabeth II, II, 2014-2015 2007
1st Session, 56th 58th Legislature New Brunswick 63-6456 Elizabeth II, II, 2014-2015 2007 1 re session, 56 58 e législature Nouveau-Brunswick 63-6456 Elizabeth II, II, 2014-2015 2007 BILL 15 PROJET DE
Plus en détailEmergency Management Act. Loi sur la gestion des urgences CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 2007, c. 15 L.C. 2007, ch. 15. À jour au 4 août 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Emergency Management Act Loi sur la gestion des urgences S.C. 2007, c. 15 L.C. 2007, ch. 15 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Last amended on August 3, 2007
Plus en détailForm of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Form of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations Règlement sur la forme des actes relatifs à certaines successions de bénéficiaires
Plus en détailResident Canadian (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Resident Canadian (Insurance Companies) Regulations Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) SOR/92-284 DORS/92-284 Current to August 4, 2015 À jour
Plus en détailAppointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appointment or Deployment of Alternates Regulations Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants SOR/2012-83 DORS/2012-83 Current to August 30, 2015 À jour
Plus en détailLoi sur la Semaine nationale du don de sang. National Blood Donor Week Act CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 2008, c. 4 L.C. 2008, ch.
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION National Blood Donor Week Act Loi sur la Semaine nationale du don de sang S.C. 2008, c. 4 L.C. 2008, ch. 4 Current to June 9, 2015 À jour au 9 juin 2015 Published by the
Plus en détailExport Permit (Steel Monitoring) Regulations. Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Export Permit (Steel Monitoring) Regulations Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) SOR/87-321 DORS/87-321 Current to August 4, 2015 À jour
Plus en détailLOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT
PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT LOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE Application of this Act 1(1) This Act applies to the following (a) persons employed by the
Plus en détailTHE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002
2-aes THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 19 [Handling
Plus en détailBILL PROJET DE WI 18 [-L. .. '- 1st Session, 53rd Legislature New Brunswick 45 Elizabeth n, 1996
-~.. '- -'..,'.~d"'~t- \i.e," >. \, --,J...,p' 'to,;,';;j \").",,,.- lj''''''' 11tPR., 2'996 [-L. 1st Session, 53rd Legislature New Brunswick 45 Elizabeth n, 1996 Ire session, 53e legislature Nouveau-Brunswick
Plus en détailNordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. SOR/90-162 DORS/90-162 Current to June 9, 2015 À jour au
Plus en détailBILL 10 PROJET DE LOI 10
Bill 10 Government Bill Projet de loi 10 Projet de loi du gouvernement 3 rd Session, 40 th Legislature, Manitoba, 62 Elizabeth II, 2013 3 e session, 40 e législature, Manitoba, 62 Elizabeth II, 2013 BILL
Plus en détailAssented to December 18, 2009 Sanctionnée le 18 décembre 2009
CHAPTER P-15.05 CHAPITRE P-15.05 Prescription Monitoring Act Assented to December 18, 2009 Sanctionnée le 18 décembre 2009 Chapter Outline Sommaire Definitions....1 advisory committee comité consultatif
Plus en détailArchived Content. Contenu archivé
ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject
Plus en détailEdna Ekhivalak Elias Commissioner of Nunavut Commissaire du Nunavut
SECOND SESSION THIRD LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NUNAVUT DEUXIÈME SESSION TROISIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NUNAVUT GOVERNMENT BILL PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT BILL 52 PROJET DE LOI N o 52 SUPPLEMENTARY
Plus en détailTERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014
NORTHWEST TERRITORIES LANDS ACT FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014 LOI SUR LES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 AMENDED BY MODIFIÉ PAR This
Plus en détailCONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to the Department of Supply and Services the Control and Supervision of the Government Telecommunications Agency and the Translation Bureau and Transferring
Plus en détailCHAPTER 101 CHAPITRE 101
CHAPTER 101 CHAPITRE 101 Adult Education and Training Act Loi sur l enseignement et la formation destinés aux adultes Table of Contents 1 Definitions Department ministère institution établissement Minister
Plus en détailLoi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d Halifax. Halifax Relief Commission Pension Continuation Act CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Halifax Relief Pension Continuation Act Loi sur la prise en charge des prestations de la de secours d Halifax S.C. 1974-75-76, c. 88 S.C. 1974-75-76, ch. 88 Current to
Plus en détailPrepaid Payment Products Regulations. Règlement sur les produits de paiement prépayés CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to September 10, 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Prepaid Payment Products Regulations Règlement sur les produits de paiement prépayés SOR/2013-209 DORS/2013-209 Current to September 10, 2015 À jour au 10 septembre 2015
Plus en détailLocal Revenue Management Implementation Regulations. Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Local Revenue Management Implementation Regulations Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales SOR/2007-245 DORS/2007-245 Current to September 10,
Plus en détailProclamation establishing three different time zones in Nunavut, for the purposes of the definition of standard time in the Interpretation Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Proclamation establishing three different time zones in Nunavut, for the purposes of the definition of standard time in the Interpretation Act Proclamation établissant
Plus en détailCONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS. 1 In this Act,
CONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS Definitions 1 In this Act, Chief Legislative Counsel means that member of the public service appointed to this position
Plus en détailLegislation Revision and Consolidation Act. Loi sur la révision et la codification des textes législatifs CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Legislation Revision and Consolidation Act Loi sur la révision et la codification des textes législatifs R.S.C., 1985, c. S-20 L.R.C. (1985), ch. S-20 Current to August
Plus en détailCODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, 2015. À jour au 30 août 2015. Last amended on December 12, 2013
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to Shared Services Canada the Control and Supervision of Certain Portions of the Federal Public Administration in each Department and Portion of the
Plus en détailPractice Direction. Class Proceedings
Effective Date: 2010/07/01 Number: PD - 5 Title: Practice Direction Class Proceedings Summary: This Practice Direction describes the procedure for requesting the assignment of a judge in a proceeding under
Plus en détailINDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.
Recipient s name 5001-EN For use by the foreign tax authority CALCULATION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS Attachment to Form 5000 12816*01 INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been
Plus en détailRule / Règle 18. 18.01 When Personal Service is Necessary 18.01 Cas où la signification personnelle est requise
SERVICE RULE 18 SERVICE OF PROCESS SIGNIFICATION RÈGLE 18 SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE 18.01 When Personal Service is Necessary 18.01 Cas où la signification personnelle est requise Originating
Plus en détailLOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5
FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5 LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY S.N.W.T. 1997,c.3 S.N.W.T. 2003,c.31 In force April 1, 2004;
Plus en détailBill 119 Projet de loi 119
1ST SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 57 ELIZABETH II, 2008 1 re SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 57 ELIZABETH II, 2008 Bill 119 Projet de loi 119 (Chapter 20 Statutes of Ontario, 2008) (Chapitre 20
Plus en détailOrder Assigning to the Minister of the Environment, the Administration, Management and Control of Certain Public Lands
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Assigning to the Minister of the Environment, the Administration, Management and Control of Certain Public Lands Décret attribuant au ministre de l Environnement
Plus en détailActs 2011 THE DIVORCE AND JUDICIAL SEPARATION (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011. SIR ANEROOD JUGNAUTH 25 th April 2011 President of the Republic
Divorce and Judicial Separation Act 2011 5/11/11 1:04 PM Page 2 2 THE DIVORCE AND JUDICIAL SEPARATION (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011 Act No. 2 of 2011 I assent SIR ANEROOD JUGNAUTH 25 th April 2011
Plus en détailBILL C-556 PROJET DE LOI C-556 C-556 C-556 CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA HOUSE OF COMMONS OF CANADA
C-6 C-6 Second Session, Forty-first Parliament, Deuxième session, quarante et unième législature, HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA BILL C-6 PROJET DE LOI C-6 An Act to amend the
Plus en détailUMANIS. Actions UMANIS(code ISIN FR0010949388 /mnémo UMS)
CORPORATE EVENT NOTICE: Offre publique de rachat PLACE: Paris AVIS N : PAR_20131212_09018_EUR DATE: 12/12/2013 MARCHE: EURONEXT PARIS Le 12/12/2013, l'autorité des marchés financiers (l'"amf") a fait connaître
Plus en détailOFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Payment Card Networks Act Loi sur les réseaux de cartes de paiement S.C. 2010, c. 12, s. 1834 L.C. 2010, ch. 12, art. 1834 [Enacted by section 1834 of chapter 12 of the
Plus en détailLoi sur le Fonds d investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre. Greenhouse Gas Technology Investment Fund Act CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Greenhouse Gas Technology Investment Fund Act Loi sur le Fonds d investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre S.C. 2005, c. 30, s. 96 L.C. 2005,
Plus en détailAccess to Basic Banking Services Regulations. Règlement sur l accès aux services bancaires de base CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Access to Basic Banking Services Regulations Règlement sur l accès aux services bancaires de base SOR/2003-184 DORS/2003-184 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août
Plus en détailBILL C-60 PROJET DE LOI C-60 C-60 C-60 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
C-60 C-60 Second Session, Forty-first Parliament, 62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-201 Deuxième session, quarante et unième législature, 62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-201 HOUSE OF COMMONS OF CANADA
Plus en détailONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief
ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Form 17E: Trial Management Conference Brief Name of party filing this brief Date of trial management conference Applicant(s) Full legal
Plus en détailRèglement sur l indemnisation en cas d accident d aviation. Flying Accidents Compensation Regulations CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Flying Accidents Compensation Regulations Règlement sur l indemnisation en cas d accident d aviation C.R.C., c. 10 C.R.C., ch. 10 Current to July 21, 2015 À jour au 21
Plus en détailOFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canada Disability Savings Act Loi canadienne sur l épargne-invalidité S.C. 2007, c. 35, s. 136 L.C. 2007, ch. 35, art. 136 Current to August 30, 2015 À jour au 30 août
Plus en détailNational Parks of Canada Businesses Regulations. Règlement sur l exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION National Parks of Canada Businesses Regulations Règlement sur l exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada SOR/98-455 DORS/98-455 Current to September
Plus en détailBill 212 Projet de loi 212
2ND SESSION, 38TH LEGISLATURE, ONTARIO 56 ELIZABETH II, 2007 2 e SESSION, 38 e LÉGISLATURE, ONTARIO 56 ELIZABETH II, 2007 Bill 212 Projet de loi 212 (Chapter 14 Statutes of Ontario, 2007) (Chapitre 14
Plus en détailBill 164 Projet de loi 164
2ND SESSION, 38TH LEGISLATURE, ONTARIO 55 ELIZABETH II, 2006 2 e SESSION, 38 e LÉGISLATURE, ONTARIO 55 ELIZABETH II, 2006 Bill 164 Projet de loi 164 An Act to amend the Consumer Protection Act, 2002, the
Plus en détailcalls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne *** Online Applications Tutorial
calls.paris-neuroscience.fr Tutoriel pour Candidatures en ligne Online Applications Tutorial 1/4 Pour postuler aux Appels d Offres de l ENP, vous devez aller sur la plateforme : calls.parisneuroscience.fr.
Plus en détailBill 21 Projet de loi 21
3RD SESSION, 36TH LEGISLATURE, ONTARIO 48 ELIZABETH II, 1999 3 e SESSION, 36 e LÉGISLATURE, ONTARIO 48 ELIZABETH II, 1999 Bill 21 Projet de loi 21 An Act to increase fairness and consumer protection while
Plus en détailThe Saskatchewan Gazette
THE SASKATCHEWAN GAZETTE, MAY 10, 2002 233 The Saskatchewan Gazette PUBLISHED WEEKLY BY AUTHORITY OF THE QUEEN S PRINTER PART II/PARTIE II Volume 98 REGINA, FRIDAY, MAY 10, 2002/REGINA, VENDREDI, 10 MAI
Plus en détailSpecial Operating Agencies Designation Regulation, amendment. Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des organismes de service spécial
THE SPECIAL OPERATING AGENCIES FINANCING AUTHORITY ACT (C.C.S.M. c. S185) Special Operating Agencies Designation Regulation, amendment LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL
Plus en détailTÅÎCHÔ COMMUNITY GOVERNMENT ACT LOI SUR LE GOUVERNEMENT COMMUNAUTAIRE TÅÎCHÔ RÈGLEMENT SUR LES DETTES (GOUVERNEMENT COMMUNAUTAIRE TÅÎCHÔ) R-142-2009
TÅÎCHÔ COMMUNITY GOVERNMENT ACT LOI SUR LE GOUVERNEMENT COMMUNAUTAIRE TÅÎCHÔ DEBT (TÅÎCHÔ COMMUNITY GOVERNMENT) REGULATIONS R-142-2009 RÈGLEMENT SUR LES DETTES (GOUVERNEMENT COMMUNAUTAIRE TÅÎCHÔ) R-142-2009
Plus en détailIf the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to:
2014-10-07 Corporations Canada 9th Floor, Jean Edmonds Towers South 365 Laurier Avenue West Ottawa, Ontario K1A 0C8 Corporations Canada 9e étage, Tour Jean-Edmonds sud 365 avenue Laurier ouest Ottawa (Ontario)
Plus en détailGrandes tendances et leurs impacts sur l acquisition de produits et services TI.
Grandes tendances et leurs impacts sur l acquisition de produits et services TI. François Banville Partenaire exécutif chez Gartner Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.
Plus en détailNotice of Ways and Means Motion to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
Notice of Ways and Means Motion to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines
Plus en détail