Gazette royale. The Royal Gazette. Notice to Readers. Avis aux lecteurs. Bureau de la directrice générale des élections
|
|
- Brian Marceau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick ISSN Vol. 163 Wednesday, October 12, 2005 / Le mercredi 12 octobre Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the editor no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday s publication. However, when there is a public holiday, please contact the editor. Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à l éditrice, à midi, au moins 7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec l éditrice. Office of the Chief Electoral Officer Bureau de la directrice générale des élections Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3, Province of New Brunswick, the following change to the original registrations has been entered in the Registry between September 1 st, 2005 and September 30 th, 2005: / Conformément à l article 149 de la Loi électorale, chapitre E-3, province du Nouveau-Brunswick, le changement suivant aux enregistrements originaux a été inscrit au registre entre le 1 er septembre 2005 et le 30 septembre 2005 : 03 DALHOUSIE-RESTIGOUCHE EAST LIBERAL PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 03) / ASSOCI- ATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI LIBÉRAL DE DALHOUSIE-RESTIGOUCHE-EST (Circonscription n o 03) Official Representative / Représentante officielle Janique Legacy 389, rue Adelaide Street, unité / Unit 2 Dalhousie, NB E8C 1B5
2 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 Business Corporations Act Notice of dissolution of provincial corporations and cancellation of the registration of extra-provincial corporations Notice of dissolution of provincial corporations Take notice that the following provincial corporations have been dissolved as of September 26, 2005, pursuant to paragraph 139(1)(c) of the Business Corporations Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices and/or documents required by the Act. Certificates of Dissolution have been issued dated September 26, Loi sur les corporations commerciales Avis de dissolution de corporations provinciales et d annulation de l enregistrement des corporations extraprovinciales Avis de dissolution de corporations provinciales Sachez que les corporations provinciales suivantes ont été dissoutes en date du 26 septembre 2005 en vertu de l alinéa 139(1)c) de la Loi sur les corporations commerciales, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du 26 septembre (C.C.I.) COUNTRY COZY INC N.B. LTD N.B. LTD N.-B. Inc ASSOMPTION CONDOS LTEE N.B. LTD N.B. LTD N.B. Inc N.B. LTD N.B. INC N.B. INC N.B. LTD N.B. Inc N.B. Ltd N.B. Ltd N.B. Inc N.B. Inc N.B. LTD N.-B. Ltée N.B. LTD N.B. Ltée N.B. INC N.B. Ltd NEW BRUNSWICK INC N.B. Ltd A TO Z SIGN SERVICE INC ACADIA SEAFOOD LTD AMC (INTERNATIONAL) INC ANHYDRITE MINERALS INC B & B STRUCTURAL GROUP INC BATHURST NORTHERN LIMITED BELANGER & SONS FEED & FARM SUPPLY CO. LTD BERNCO WOODWORK MANUFACTURING INC Bioscan (Moncton) Inc BO-PLASTIK INC Bobarino s Pizza Ltd BOULEVARD MEDICAL CENTRE LTD BREWER HOLDINGS LTD C.D.M. FOODS LIMITED CanAm Health Source Inc CAP ROUGE PIZZA INC CENTRE D ENTRETIEN POUR PISCINE QUALI-T INC./QUALI-T POOL CARE CENTRE INC Chamcan Limited Coastal Cage Repair Ltd CONTROLLED AIR MANAGEMENT LIMITED CRANDLEMIRE AUTO BROKERS LTD Dale Bonney Builders Inc Dave Goodwin Consulting Inc De Kruyff Financial Group Ltd DÉPANNEUR P TIT COVE CONVENIENCE INC DEVLIN CONSTRUCTION (1999) LTD DRC FREIGHT INC ETTORE FASHION TAILOR LTD Extreme Advantage Consulting Inc FREDERICK R. TODD PROFESSIONAL CORPORATION FRITURES LAMEQUE LTEE Fundy Project Management Inc G & G Bernier Windows & Doors Inc GEORGE MCWAID S AUTO REPAIR LTD GERALD T. REGAN PROFESSIONAL CORPORATION GIENCO CONSTRUCTION (1990) LTD GREAT CIRCLE MARINE SERVICES INC HILLCREST NURSERIES AND GREENHOUSES INC HK-SAR Associates Limited Hygaard TV & Film Production Inc INSTITUT JOUVANCE LTÉE ISOLATION ST-COEUR LTEE ISP New Brunswick Ltd J.P.R.M. ENTREPRISE INC Janet Case Professional Corporation JWR INSURANCE & INVESTMENTS LTD L G Plumbing & Heating Ltd LAWTON S MECHANICAL INC Les Croisières du Cajun Inc LOVING CARE HOME CARE INC M.J. BOURQUE CONSTRUCTION INC MAM PARALEGAL INC MARITIME GARDENERS LIMITED MCTS INDUSTRIES LTD MICHELLE C. PARKER SPEECH AND LANGUAGE SERVICES INC MORTON S PROPERTY MAINTENANCE LTD MURRAY MASONRY COMPANY, LTD MYBEC BUILDERS LTD NET A SEC LTEE NORTHCO PARTS LTD OXYGEN SPORTS BAR INC Paul s Auto Crushing Ltd PECHERIES CATIE MICHELINE LIMITEE PECHERIES WILBERT SMITH INC Priority Sound & Lights Inc PRO-TARC LTD R & W Cigarette Tube Ltd R.J. Bourque Renovations Ltd RISKY BUSINESS LTD Riverbend Tours Inc ROBERT W. TAYLOR TRUCKING INC ROOFCHEK INC RVC DRYWALL INC SALAISON GAUVIN LTEE-GAUVIN PACKERS LTD SARAI ENTERPRISES LTD ScheduleCare Inc SCOOP S INC SHERRITT POWER CORPORATION SMC (CANADA) LTD SOUTHTIDE HOLDINGS LTD SUPERIOR VENTURES LTD TEASERS TEAHOUSE AND ESPRESSO BAR LTD Tel Quest 2000 Inc TODAY S REALTY LTD TUFF COAT CANADA INC UNITED BUILDING SUPPLIES LTD VILLAGE MART LTD Voice2Text Inc W. HOPEY INVESTMENTS INC WARREN SALES INC WITS END GREENHOUSE LIMITED ZEEBEX LTEE LTD
3 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 Notice of cancellation of registration of extra-provincial corporations Take notice that the registrations of the following extra-provincial corporations have been cancelled as of September 26, 2005, pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Business Corporations Act as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices and/or documents required by the Act: Avis d annulation de l enregistrement des corporations extraprovinciales Sachez que l enregistrement des corporations extraprovinciales suivantes a été annulé en date du 26 septembre 2005 en vertu de l alinéa 201(1)a) de la Loi sur les corporations commerciales, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi : CANADA INC ATLAS SUPPLY CHAIN SERVICES LIMITED FIRECO INC FOOTHILL CAPITAL CORPORATION GEST MAG INC GESTION GABRIEL MUNOZ INC Philip Services Inc. Companies Act Loi sur les compagnies Notice of dissolution of provincial companies Take notice that the following provincial companies have been dissolved as of September 26, 2005, pursuant to paragraph 35(1)(c) of the Companies Act, as the said companies have been in default in sending to the Director fees, notices and/or documents required by the Act. Certificates of Dissolution have been issued dated September 26, Avis de dissolution de compagnies provinciales Soyez avisé que les compagnies provinciales suivantes ont été dissoutes en date du 26 septembre 2005 en vertu de l alinéa 35(1)c) de la Loi sur les compagnies, puisque lesdites compagnies ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du 26 septembre CAMP JEUNESSE RICHELIEU INC CENTENNIAL COMMUNITY CLUB, ROACHVILLE, INC CENTRE DE LOISIRS DU LAC BAKER INC CLUB D AGE D OR - GLOUCESTER- GOLDEN AGE CLUB INC Hepatitis C Moncton Inc ISLAND HERITAGE SEA VEGETABLES HARVESTERS ASSOCIATION INC KINETTE CLUB OF THE MIRAMICHI INC LA MARINA DE BOUCTOUCHE INC MSGR. GODIN CHARITIES INC./LES CHARITÉS MGR. GODIN INC NEW BANDON - SALMON BEACH FIRE DEPARTMENT INC NEW BRUNSWICK WILDLIFE FEDERATION INC River Valley Trail Riders Inc SAINT JOHN YOUTH HOCKEY ASSOCIATION, INC SALEN INC ST. STEPHEN HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION INC THE KINSMEN CLUB OF EDMUNDSTON, INC. Business Corporations Act PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of incorporation has been issued to: Loi sur les corporations commerciales SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré référence année mois jour N.B. Inc. 1, rue du Réservoir Street Saint-Jacques Saint-Jacques, NB E7B 1R9 N.V. Godin Entreprise Inc. 50, rue Derby Street Moncton Moncton, NB E1C 6Y5 Les Productions Région Sauvage Inc. 20, rue du Pont Street Saint-Jacques Saint-Jacques, NB E7B 1H4 INLAY N.B. INC. 399, chemin Flume Ridge Road Comté de Charlotte Comté de Charlotte County, NB E6K 2B7 County CBS TRUCKING 2005 LTD. 60, chemin Charters Settlement Road Charters Settlement Charters Settlement, NB E3C 1Y4 DR PATRICK MARCOTTE CORPORATION 992, rue Barachois Street Dieppe PROFESSIONELLE INC. Dieppe, NB E1A 7E4
4 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 Quality Fire Protection Ltd. 79, chemin Pont-Rouge Road Memramcook Memramcook, NB E4L 1T6 GESTION R2 MANAGEMENT INC. 59, rue Water Street Campbellton C.P. / P.O. Box 2 Campbellton, NB E3N 3G1 Ing Mag Ltd. 204, chemin Lime Kiln Road Letang Letang, NB E5C 2A8 Nettoyage M.D.B. Cleaning Ltée 4976, route / Highway 340 Notre-Dame Notre-Dame-des-Érables, NB E8R 1T6 des-érables NEW BRUNSWICK INC , avenue Bernon Avenue Bathurst NOUVEAU-BRUNSWICk INC. Bathurst, NB E2A 3W9 ULTRA AIR CONDITIONING LIMITED 528, chemin McAllister Road Riverview Riverview, NB E1B 4G1 SPI SPECIALIZED PROTECTION INC. 31, allée Cardigan Lane Moncton Moncton, NB E1C 0B NEW BRUNSWICK INC. 1522, avenue Bernon Avenue Bathurst Bathurst, NB E2A 3W9 Pro Vision Home Inspections Inc. 75, promenade Glenwood Drive Moncton Moncton, NB E1A 2M8 F & S Contracting Ltd. 29, allée Beek Lane Storeytown Storeytown, NB E9C 1T9 Tormond Services Limited 660, avenue Rothesay Avenue, unité / Unit E Saint John Saint John, NB E2H 2H4 J.R. DELIVERY SERVICE LIMITED 2634, route / Highway 515 Sainte-Marie Sainte-Marie-de-Kent, NB E4S 2E5 de-kent Dr. J. J. Morales Professional Corporation 19, rue Woodland Hill Street Perth-Andover Perth-Andover, NB E7H 5H4 TRANS ATLANTIC INFOTECH LTD. 121, rue Germain Street Saint John NB INC. 20, chemin Bourque Road Bouctouche Bouctouche, NB E4S 2X N.B. Inc. 77, rue Westmorland Street, bureau / Suite 600 Fredericton Fredericton, NB E3B 6Z3 Dr. C. Andrew Nice Professional Corporation 39, rue Canterbury Street Saint John Saint John, NB E2L 4S1 Placemat Marketing Group Inc. 996, route / Highway 525 Sainte-Marie Sainte-Marie-de-Kent, NB E4S 2H5 de-kent Event Medic Service Inc. 359, chemin Fredericksburg Road Fredericksburg Fredericksburg, NB E6B 1J5 SIMONSON CONSTRUCTION LTD. 1, chemin Beach Road Eel River Bar Eel River Bar, NB E8C 2Y N.B. Ltd. 22, rue King Street Saint John Saint John, NB E2L 1G N.B. Inc. 127, rue George Street Fredericton Fredericton, NB E3B 1J2 Healing Vitality Ltd. 7, rue Beech Street Moncton Moncton, NB E1A 4G3 Dr C. Wybouw et Dre G. Côté C.P. Inc. 458, chemin LeBlanc Road Dieppe Dieppe, NB E1A 7N4 T n G Convenience Ltd. 1425, route / Highway 620 Esteys Bridge Esteys Bridge, NB E3A 6M9 Torrent Technical Inc. 44, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 Saint John
5 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 ENTREPRISES B.C.M. ENTERPRISES INC. 549, rue Victoria Street Edmundston Edmundston, NB E3V 2K9 DRAGON POWDER COATINGS INC. 91, chemin Taylor Lake Road Willow Grove Willow Grove, NB E2S 1P New Brunswick Ltd. 16, cour Baker Brook Court New Maryland New Maryland, NB E3C 1B4 FILLION HOLDINGS LTD. 4022, route / Highway 105 Northampton Northampton, NB E7N 1E1 D MAZEROLLE & ASSOCIATES INC. 348, chemin Milford Road Nord / North Saint John Saint John, NB E2M 4R7 Front Gate GMAC Real Estate Ltd. 57, rue Carleton Street, 4 e étage / 4 th Floor Fredericton Fredericton, NB E3B 3T2 Centre Psychodiagnostic Center Inc. 293, rue Bahama Street Dieppe Dieppe, NB E1A 6M NB LTD. 95, chemin Morrison Road Rossville Rossville, NB E6G 2N4 Mauser Canada Ltd. 44, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 Saint John Fundy Bay Trading Company, Inc. 1, Brunswick Square, bureau / Suite 1500 Saint John C.P. / P.O. Box 1324 Saint John, NB E2L 4H8 Edge Systems Inc. 46, promenade Maliseet Drive Rothesay Rothesay, NB E2E 2G3 E & W HACHEY GAS BAR INC. 7, rue Rigley Street Miramichi Miramichi, NB E1N 3B N.B. Ltd. 706 B, chemin Coverdale Road Riverview Riverview, NB E1B 3L N.B. Ltd. 372, rue Beauséjour Street Dieppe Dieppe, NB E1A 1Y6 NOTICE OF CORRECTION / AVIS D ERRATUM Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales In relation to a certificate of incorporation issued on July 27, 2005 under the name of Dr. Josoph Teakles C.P./P.C. Inc., being corporation #620326, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the corporation name from Dr. Josoph Teakles C.P./P.C. Inc. to Dr. Joseph Teakles C.P./P.C. Inc.. Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 27 juillet 2005 à «Dr. Josoph Teakles C.P./P.C. Inc.», dont le numéro de corporation est , le directeur a délivré, conformément à l article 189, un certificat corrigé de constitution faisant passer la raison sociale de la corporation de «Dr. Josoph Teakles C.P./P.C. Inc.» à «Dr. Joseph Teakles C.P./P.C. Inc.». PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of continuance has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de prorogation a été émis à : Previous Reference Jurisdiction Number Date Registered Office Compétence Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré antérieure référence année mois jour INTEC BILLING (HOLDING) Bureau / Suite 1000 Saint John Canada CANADA LIMITED 44, côte Chipman Hill C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A Evention Technologies, Inc. Bureau / Suite C Fredericton Ontario , chemin Hanwell Road Fredericton, NB E3B 2R7 VAN NELLE CANADA LIMITED 147, chemin Heller Road Woodstock Nouvelle-Écosse / VAN NELLE CANADA LIMITEE Woodstock, NB E7M 1X4 Nova-Scotia
6 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 INTEC BILLING CANADA Bureau / Suite 1000 Saint John Canada LIMITED 44, côte Chipman Hill C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification a été émis à : Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour DELCO ENTERPRISES LTD LES INVESTISSEMENTS DE LAMEQUE LTEE NEGUAC PHARMACY LIMITED-PHARMACIE NEGUAC LIMITEE GILLES CORMIER ELECTRIC INC GRAND MANAN BOATS LTD DELCO FOREST PRODUCTS LTD IMPERIAL BRUSH CO. LTD BRENT BISHOP REALTY LTD DR. W. R. RECTOR PROFESSIONAL CORPORATION R. HOLMES PHARMACY LTD HIGGINS GENERAL INSURANCE LTD DR. LINDA BOULAY CORPORATION PROFESSIONNELLE INC STELOR HOLDINGS LTD CRESCENT ENGINEERING GROUP LIMITED W. E. HODGES SURVEYS LTD DR. JOHN STEWART PROFESSIONAL CORPORATION HILLMAR FARMS LTD DR. ROBERT I. HATHEWAY PROFESSIONAL CORPORATION SPLITROCK ENTERPRISES LTD PIERRE FINN C.P. INC MOFFITT MOTORS LTD Anderson-McTague & Associates Ltd Dr. Stephen A. Willis Professional Corporation M&S Food Service Ltd LIGHTHOUSE COMMUNICATIONS INC PAWS PET RESORT INC NORMA THERIAULT HOLDINGS INC Wharton Resources Limited BOISSONNAULT McGRAW & ASSOCIATES LTD McSheffery Property Holdings Inc
7 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 NOTICE OF CORRECTION / AVIS D ERRATUM Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales In relation to a certificate of amendment issued on January 4, 2005 under the name of Automatic Heat Ltd., being corporation # notice is given that pursuant to s.189 of the act, the Director has issued a corrected certificate of amendment replacing page 1 of Schedule 1 to Form 3. Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 4 janvier 2005 à «Automatic Heat Ltd.», dont le numéro de corporation est , le directeur a délivré, conformément à l article 189 de la Loi, un certificat corrigé pour remplacer la page 1 de l annexe 1 à la formule 3. In relation to a certificate of amendment issued on February 1, 2005 under the name of CANlink Capital Inc., being corporation #603268, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amendment correcting the corporation name from CANlink Capital Inc. to CANLink Capital Inc. Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 1 er février 2005 à «CANlink Capital Inc.», dont le numéro de corporation est , le directeur a délivré, conformément à l article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer la raison sociale de la corporation de «CANlink Capital Inc.» à «CANLink Capital Inc.». In relation to a certificate of amendment issued on May 20, 2005 under the name of Dr. Tim Chaisson Professional Corporation, being corporation #048941, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amendment correcting the corporation name from Dr. Tim Chaisson Professional Corporation to Bown Chaisson Professional Corporation. Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 20 mai 2005 à «Dr. Tim Chaisson Professional Corporation», dont le numéro de corporation est , le directeur a délivré, conformément à l article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer la raison sociale de la corporation de «Dr. Tim Chaisson Professional Corporation» à «Bown Chaisson Professional Corporation». PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment which includes a change in name has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification contenant un changement de raison sociale a été émis à : Date Previous name Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour Dieppe Blvd. Convenience Ltd. YOCO HOLDINGS LTD GAL HOLDINGS LTD. G. A. LEVESQUE LTEE Fundy Retail Ltd N.B. Ltd BH Development Ltd N.B. LTD GDPI Holdings Ltd N.B. LTD Marine Harvest Canada Inc. Stolt Sea Farm Inc TITAN METALS GROUP INC. LCI Metal Fab. Inc Veracity Communications Inc N.B. Ltd DAMIL PRODUCTIONS INC. Angel Flicks Inc Canadian Fundy Investments Inc. Eastern Canadian Industrial Park Group Inc COREY FORD LTD. COREY MOTORS INC The Atlantic Pain Clinic Inc N.B. Inc Dr. Josoph Teakles C.P./P.C. Inc. Dr. Joseph Teakles C.P./P.C. Inc KENBAR HOLDINGS INC. Ken Bar Holdings Inc C & D DEMERCHANT INC. Demerchant Chipping Ltd N. R. APARTMENTS LTD N. B. INC
8 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amalgamation has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de fusion a été émis à : Reference Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Address Registered Office Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Adresse Bureau enregistré référence année mois jour N. B. INC N.B. INC. 22, rue Brandon Street Moncton N.R. APARTMENTS LTD. Moncton, NB E1C 7E6 LES ENTREPRISES AMI LES ENTREPRISES AMI 25-46, boulevard Caraquet LIMITÉE LIMITEE Saint-Pierre Boulevard N.-B. LTEE Ouest / West Caraquet, NB E1W 1B8 G.M. PIZZERIA (2005) LTEE DARLINGTON VIDEO 165, rue Roseberry Street Campbellton (LTEE) LTD. Campbellton, NB E3N 2H2 G.M. PIZZERIA LTD. Maritime Broadcasting System MARITIME BROADCASTING 1000, boul. St. George Blvd. Moncton Limited SYSTEM LIMITED/ Moncton, NB E1E 2E1 CHOY-FM Limitee/ BRAS D OR BROADCASTING LIMITED PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of dissolution has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de dissolution a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré référence année mois jour KINGSFIELD INVESTMENTS LTD. 255, rue Main Street Fredericton Fredericton, NB E3A 1E1 VALLEE AMUSEMENT INC. 170, rue Principale Street Saint-Basile Saint-Basile, NB E7C 1H6 SPROUTCO INC. 107, rue Main Street Florenceville Florenceville, NB E7L 1B2 K.B. WEEKS & SON LTD. RR 3 Harvey Harvey, NB E0H 1H0 Entreprise H. Y. Poirier Inc. 1330, route / Highway 260 Saint-Quentin C.P. / P.O. Box 1531 Saint-Quentin, NB E8A 1A4 AVANTRE Inc. 44, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 Saint John Saint John, NB E2L 2A9 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a restated certificate of incorporation has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution mise à jour a été émis à : Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour LES INVESTISSEMENTS DE LAMEQUE LTEE
9 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of revival has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de reconstitution a été émis à : Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour A.D.L. ENTERPRISES LTD D. BABINEAU DRUGS INC M & M VENTURE CAPITAL CORP OFFICE BROKERAGE & CONSULTING CORP THERMO CRS HOLDINGS LTD PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Reference Number Date Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour SERVICES FINANCIERS FILLION ET Québec / Quebec Richard Mireault ASSOCIÉS INC. 1515, route / Highway 470 West Branch, NB E4W 3G ALBERTA LTD. Alberta SMSS Corporate Services (NB) Inc , côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A Canada Inc. Canada Claude Fecteau , rue Notre-Dame Street Atholville, NB E3N 4E4 CanadAlger N.S. Inc. Canada Kader Berkane , rue Cyril Street Dieppe, NB E1A 8R6 Schaeffler Canada Inc. Ontario John Hanson , rue Queen Street, bureau / Suite 400 C.P. / P.O. Box 310 Fredericton, NB E3B 4Y9 MCNEILL RISK MANAGEMENT Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc SERVICES INC. 44, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A ATS Andlauer Transportation Services Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc GP Inc. 44, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A ROGERS BROADCASTING LIMITED Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc , côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A
10 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment of registration of extraprovincial corporation has been issued to: BLACKMONT CAPITAL INC. FIRST ASSOCIATES INVESTMENTS INC SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification de l enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Reference Number Date Previous name Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of amalgamated corporation has been issued to the following extra-provincial corporations: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d enregistrement d une corporation extraprovinciale issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Reference Agent and Address Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Address Représentant et Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Adresse adresse référence année mois jour WOLSELEY INDUSTRIAL WOLSELEY INDUSTRIAL 5145, chemin North SMSS Corporate Services PRODUCTS GROUP INC.- PRODUCTS GROUP INC.- Service Road (NB) Inc. WOLSELEY GROUPE DE WOLSELEY GROUPE DE Burlington, ON L7L 5H6 C. Paul W. Smith PRODUITS INDUSTRIELS PRODUITS INDUSTRIELS INC. INC. The Warren Paving & THE WARREN PAVING & 5 th Floor / 5 e étage Deborah M. Power Materials Group Limited MATERIALS GROUP 7880, rue Keele Street LIMITED Concord, ON L4K 4G7 SUPERIOR PLUS INC. SUPERIOR PLUS INC th Avenue / Eric LeDrew SUPERIEUR PLUS INC. SUPERIEUR PLUS INC. 5 e avenue Calgary, AB T2P 3H5 TRIMAC TRIMAC th Avenue / SMSS Corporate Services TRANSPORTATION TRANSPORTATION 5 e avenue (NB) Inc. SERVICES INC. SERVICES INC. Calgary, AB T2P 5A3 Rodney D. Gould Companies Act PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, letters patent have been granted to: Loi sur les compagnies SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes ont été émises à : Reference Number Date Head Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Address / Adresse Siège social référence année mois jour Waterford Valley Development Association Inc. 260, avenue Church Avenue Sussex C.P. / P.O. Box 5062 Sussex, NB E4E 5L2 ST. CROIX SPORTSMAN CLUB INC. 184, rue King Street St. Stephen C.P. / P.O. Box 188 St. Stephen, NB E3L 2X1 The Spot Ministries Inc. 117, rue Pleasant Street Moncton Moncton, NB E1A 2V3 Comité de Soutien aux Personnes Dyslexiques 83 C, rue Beauséjour Street Saint-Louis De Kent Inc. Saint-Louis-de-Kent, NB E4X 1A6 de-kent Les Tigres du Restigouche Jr. A Tigers Inc. 44, boulevard Salmon Boulevard Campbellton C.P. / P.O. Box 70 Campbellton, NB E3N 3G1 BIRDTON COMMUNITY ASSOCIATION 1327, chemin Kingsley Road Birdton AND TRUST INC. Birdton, NB E3A 6E2
11 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 MANOIR DU MASCARET INC. 100, rue Notre-Dame Street Memramcook Memramcook, NB E4K 3W3 SALISBURY LIONS SENIOR CITIZENS 83, rue Horsman Street Salisbury COMPLEX (2005) INC. Salisbury, NB E4J 2H3 FUNDY BAY FESTIVAL INC. 61, rue Pitt Street, app. / Apt. 1 Saint John Saint John, NB E2L 2V7 NIMROD GUN CLUB LTD. 1019, chemin Russellville Road Russellville Russellville, NB E1V 7G3 Lakeville Corner Baptist Church, Inc. 1180, route / Highway 690 Maquapit Maquapit, NB E4B 1R2 The Moncton Regional Learning Council Inc. 60, rue Williams Street Moncton Moncton, NB E1C 2G5 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, supplementary letters patent have been granted to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes supplémentaires ont été émises à : Reference Number Date Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale référence année mois jour CENTRE CULTUREL DE CARAQUET INC CITIZENS FOR THE RESTORATION OF HAVELOCK INC PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, supplementary letters patent, which include a change in name, have been granted to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale, ont été émises à : Date New Name Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour CLUB RAINBOW INC. Salle Grand-Barachois Hall Inc NEW BRUNSWICK CURLING ASSOCIATION New Brunswick Curling Association Inc INC. Association de Curling du Nouveau-Brunswick Inc. LEAD CORPORATION CLÉ INC. CBDC Westmorland Albert Inc PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the following company is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act: SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituée en vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies : Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour NEW BRUNSWICK AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION INC ASSOCIATION MOTO-TOURISME ACADIENNE INC REGROUPMENT SOCIO-CULTUREL & RECREATIF DU MADAWASKA INC Le Regroupement des Producteurs de Bleuets de la Grande Rivière Tracadie Inc
12 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 Partnerships and Business Names Registration Act PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of business name has been registered: Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour KAMELEON MUSIK Danny Thibodeau 70, avenue Joyce Avenue, unité / Unit Moncton, NB E1A 4N2 Atlantic Pet Grooming Laurie Morgan 75, avenue Whitney Avenue Moncton, NB E1C 8C5 L.F.M. Memorial Academy Shannon Mather 372, chemin Rennie Road Miramichi, NB E1V 5Z5 Sunsational Tanning Salon Tanya Trevors 121, chemin French Fort Road Miramichi, NB E1V 5N7 Kerry Ross Forest Products Kerry Ross 402, route / Highway Lower Newcastle, NB E1V 7G1 SALON COIFFURE EVANA Monique Arseneau 115, rue Francis Street Dieppe, NB E1A 7V2 MOCCASIN ROOM Oromocto Band 4, cour Hiawatha Court Oromocto, NB E2V 2J2 HIAWATHA ROOM Oromocto Band 4, cour Hiawatha Court Oromocto, NB E2V 2J2 NIKIA ROOM Oromocto Band 4, cour Hiawatha Court Oromocto, NB E2V 2J2 WELAMOOKTOOK ROOM Oromocto Band 4, cour Hiawatha Court Oromocto, NB E2V 2J2 TANPOPO BATH & BODY FARTHER EAST ASIAN Mark Istvanffy IMPORTS INC. 4952, rue Main Street Dorchester, NB E4K 2Z1 Foyer L & L Laforge Lisa Laforge 11, chemin Waddell Road DSL de / LSD of Saint-André, NB E3Y 3L7 BISTRO CADIEN N.B. Inc. 49, avenue Pascal Avenue Dieppe, NB E1A 2C7 Energy Solutions Downeast Ben Nyssen 76, chemin McLeod Road Lower Millstream, NB E5P 3J8 BRIAN MORIN GOUTTIÈRES Brian Morin 144, avenue Belisle Avenue D ALUMINIUM Edmundston, NB E3V 3W7 Unshackled Freedom Ministry Elizabeth Jordan 3949, route / Highway Joanne Quigley Newcastle Creek, NB E4B 2J2 Rick Quigley Qcons Furniture Irvin Roy 670, chemin Malauze Road Glencoe, NB E3N 4W6 KG Synergy Group Kathy Godbout 114, croissant Magnolia Crescent Moncton, NB E1A 8C5 BRUNSWICK MANAGEMENT Christopher H. Wentzell 56, boulevard Fairway Boulevard CONSULTING Riverview, NB E1B 1T3 S P Q R ENTERPRISES Antonio B. Colella 167, rue Charlotte Street Saint John, NB E2L 2J6
13 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 Body Moves Leah J. Nixon 1, chemin Catchcart Road Rollingdam, NB E5A 2J7 BAD AMY MOTION PICTURES Chuck Elgee 71, allée Cains Brook Lane New Maryland, NB E3C 1J3 Toilettage chez Aspen Lisette Arseneault 167, chemin Saint-André Road DSL de / LSD of Saint-André, NB E3Y 3N7 TIPS-N-TOES ESTHETICS Kimberly Carney 2, rue Park Street Minto, NB E4B 3K9 Belledune Apostolic Revival Church Leo Cook 4278, rue Main Street Belledune, NB E8G 2T4 SITTING PRETTY DOG CARE Erin K. Grant 380, route / Highway Hartford, NB E7M 5J5 GOODS FROM THE WOODS Simon J. Mitchell 6931, route / Highway Dumfries, NB E6G 1P3 Juliette s Pottery - Studio & Store Juliette Scheffers 2098, route / Highway Harvey, NB E6K 1L4 B-KLEEN JANITORIAL SERVICES Jean Boudreau 48, 42 e Avenue / 42 nd Avenue Edmundston, NB E3V 2Z3 Carten s Plumbing Brent Carten 40, chemin Welshpool Back Road Welshpool, NB E5E 1G9 Country-Side Small Engine Repair Joseph Archibald 12900, route / Highway Squaw Cap, NB E3N 6G7 Home Grown Productions Matthew Richard Thomas 158, rue Charlotte Street, app. / Apt McGuire Fredericton, NB E3B 1L2 The Bingo Paper Company ALBERTA LTD. SMSS Corporate Services (NB) Inc , côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000 C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A Nich & Sock Plumbing Aaron Nicholas 33, rue Second Street Première Nation de Tobique / Tobique First Nation, NB E7H 4V4 V.S. TECHNIQUES Joël Landry 43, rue Émile Street Saint-Basile, NB E7C 2H5 The Original Basket Boutique Lori Arsenault-Gaudet 67, promenade Ashfield Drive Quispamsis, NB E2G 1R2 BALANCED AIR Daniel James Russell Smith 152, chemin Garden Grove Road Lincoln, NB E3B 7G8 The Pear Tree Canadian Bistro Carolyn Poirier 21, rue Bridge Street Sackville, NB E4L 3N6 The Library Lounge NB Inc. 440, rue King Street Fredericton, NB E3B 5B4 Royama Design Sami Royama 61, rue Bridge Street Sackville, NB E4L 3N8 Wellness Guru Lisa Morneault 6, rue des Trembles Street Saint-Jacques, NB E7B 1R6 PING SOLUTIONS Ming Haw Leong 749, rue Montgomery Street Fredericton, NB E3B 2X7 Productions Acadieclick Hugues Landry 242, rue Jones Street Moncton, NB E1C 6K6 Jeff Lyons Renovations Jeffery Weyman Lyons 35, Highland Heights Estate(s) Nord-Est / North East Taymouth, NB E6C 1Y2 Dandee Mobile Wash Dianna Allain 115, promenade Woodhaven Drive, app. / Apt Saint John, NB E2K 4M3
14 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 Bain Aroma Dominique Landry 15, allée Vanessa Lane Notre-Dame, NB E4V 3H6 B&J AUTO SERVICES John Valdron 549, rue Victoria Street Dalhousie, NB E8C 2V6 T.S. Marine Todd Steeves 1364, chemin Ryan Road Moncton, NB E1G 2V3 Chockers Consulting Ken Cullihall 23, rue Talith Street Moncton, NB E1E 4V4 Flavie s Lorraine Levesque 999, chemin Old Black River Road Saint John, NB E2J 4S9 The Conscious Journey to Truth & Clarity Rita Steele 14, promenade Greenwood Drive Quispamsis, NB E2E 2T4 J Reno Carpentry Jason Green 1765, chemin Westfield Road Saint John, NB E2M 6B7 Intercomm Technology Solutions Gordon Kerr 224, rangée Roderick Row Saint John, NB E2M 4J8 D & S TROPHY CONSULTING Douglas Hall 16, rue Peters Street Gagetown, NB E5M 1G2 Base Gagetown and Area Fact-Finders Vaughn Blaney 255, chemin Restigouche Road Project Oromocto, NB E2V 2H1 Murray s Pub Stacey Murray Unité / Unit , chemin Manawagonish Road Ouest / West Saint John, NB E2M 3Y4 A NEW DAY ESTHETICS Erica Wilkinson 73, avenue Katie Avenue Douglas, NB E3A 9K6 Cafe L Artyshow Pascal Lejeune 445, rue Principale Street, pièce / Room Nord / North Petit-Rocher, NB E8J 1L9 Middle Audio Malcolm Boyce 3, rue Cresthill Street Saint John, NB E2J 4L2 Pendlebury Press David Sullivan 339, rue Water Street Saint Andrews, NB E5B 2R2 Papa and Boys Trucking Robert Murphy 5, rue Prospect Street Doaktown, NB E9C 1C3 G P Couturier Construction Enr. Gaetan Couturier 12, chemin Savoie Road Saint-Basile, NB E7C 1Y2 Donna Moorcroft, Registered Donna Moorcroft 670, chemin Campbell Settlement Road Massage Therapist Hartfield, NB E6G 2A1 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business name has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d appellation commerciale a été enregistré : Address of Business Reference or Agent Number Date Registrant of Certificate Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Enregistreur du certificat du représentant référence année mois jour SIGHT AND SOUND Larry D. Dickinson 170, promenade Canterbury Drive Fredericton, NB E3B 4L9 Quality Transmissions Cecil W. Weldon 6, rue Lawrence Street Moncton, NB E1G 2T1 T. HILL S AUTO PARTS Todd Darren Hill 211, chemin Waterville Road Waterville, NB E2V 3S4
15 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 ETI SUPERIOR PLUS INC. Eric LeDrew SUPERIEUR PLUS INC. 655, rue Main Street C.P. / P.O. Box 1368 Moncton, NB E1C 8T6 ETI ENERGY TRANSPORTATION SUPERIOR PLUS INC. Eric LeDrew SUPERIEUR PLUS INC. 655, rue Main Street C.P. / P.O. Box 1368 Moncton, NB E1C 8T6 Mr. Plow Peter Debly 1203, chemin Loch Lomond Road Saint John, NB E2J 3V4 WebAcadie Steve Fournier 602, rue du Portage Street Caraquet, NB E1W 1B6 DVA Navion Navion Financial Development Bureau / Suite Systems Inc. 44, côte Chipman Hill C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A Wellness Aspirations Santé Chantal Deschenes 72, rue du Ruisseau Street Dieppe, NB E1A 8B3 R J S Digital Images Roger J. Smith 11, cour Acacia Court Fredericton, NB E3B 1Y7 Freedom 55 Financial London Life Insurance Company Bureau / Suite , rue Charlotte Street Saint John, NB E2L 2H6 Financiere Liberte 55 London Life Insurance Company Bureau / Suite , rue Charlotte Street Saint John, NB E2L 2H6 Freedom 55 Financial/ London Life Insurance Company Bureau / Suite Financiere liberte 55 40, rue Charlotte Street Saint John, NB E2L 2H6 Echecs Interscolaires Franco Frenette 304, rue Sunset Street Beresford, NB E8K 2G6 ICG PROPANE SUPERIOR PLUS INC. Eric LeDrew SUPERIEUR PLUS INC. 655, rue Main Street C.P. / P.O. Box 1368 Moncton, NB E1C 8T6 Medic Plus Denis R. Desjardins 123, rue Canada Street Edmundston, NB E3V 1V7 SUPERIOR PROPANE SUPERIOR PLUS INC. Eric LeDrew SUPERIEUR PLUS INC. 655, rue Main Street, bureau / Suite 300 C.P. / P.O. Box 1368 Moncton, NB E1C 8T6 ALLROC SUPERIOR PLUS INC. Eric LeDrew SUPERIEUR PLUS INC. 655, rue Main Street, bureau / Suite 300 C.P. / P.O. Box 1368 Moncton, NB E1C 8T6 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l activité ou de cessation d emploi de l appellation commerciale a été enregistré : Date Address Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Adresse Numéro de référence année mois jour ATLANTIC PET GROOMING 553, chemin Mountain Road Moncton, NB E1C 2N6 Nettoyage M.D.B. Cleaning 4976, route / Highway Notre-Dame-des-Érables, NB E8R 1T6
16 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 CBS Trucking 60, chemin Charters Settlement Road Charters Settlement, NB E3C 1Y4 N. V. Godin Entreprise 50, rue Derby Street Moncton, NB E1C 6Y5 ULTRA AIR CONDITIONING 528, chemin McAllister Road Riverview, NB E1B 4G1 SWEET PEA PRODUCTS 111, rue St. James Street Woodstock, NB E7M 2T3 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business Reference or Agent Number Date Adresse du commerce Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour CATCH OF THE DAY WEIR & Clarence Blanchard 48, chemin Armstrong Loop Road COMPANY Darcy Russell Pennfield, NB E5H 1W7 The Flying Frog Michelle Chisick 477, rue Paul Street Rachel Chisick Dieppe, NB E1A 4X5 G.A. LEVESQUE REG D Gal Holdings Ltd. 180, route / Highway MS Trucking Ltd. C.P. / P.O. Box 7966 Grand-Sault / Grand Falls, NB E3Z 3E9 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of firm name has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement de raison sociale a été enregistré : Address of Business or Agent Reference Adresse du Number Date Previous Name commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale du représentant référence année mois jour GENUITY CAPITAL MARKETS/ Genuity Capital Markets/ , rue King Street MARCHES DES CAPITAUX GENUITY Marches de Capitaux Genuity Ouest / West Toronto, ON M5H 3Y2 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de dissolution de société en nom collectif a été enregistré : Date Address Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Adresse Numéro de référence année mois jour Flavie s 237, rue Union Street Saint John, NB E2L 1B4
17 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of membership of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d associé d une société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Date Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour GE Vehicle and Equipment Leasing/ General Electric Canada Inc GE Location De Vehicules et D Equipements GE Vehicle and Equipment Leasing/ GE Capital Vehicle and GE Capital Vehicle and GE Location De Vehicules et D Equipements Equipment Leasing Inc. Equipment Leasing Company Solutions d affaires Exortal Business Marc-Samuel David Michel Melanson Limited Partnership Act Loi sur les sociétés en commandite PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has been filed: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite extraprovinciale a été déposée par : Principal place in Reference New Brunswick Agent and Address Number Date Principal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour Protectron Limited Partnership/ Saint John Manitoba SMSS Corporate Services Protectron Societe en Commandite (NB) Inc. Bureau / Suite , côte Chipman Hill NCE DIVERSIFIED FLOW- Saint John Ontario SMSS Corporate Services THROUGH (05-2) LIMITED (NB) Inc. PARTNERSHIP Bureau / Suite , côte Chipman Hill Saint John, NB E2L 2A9 Canadian Dominion Resources Saint John Ontario SMSS Corporate Services II Limited Partnership (NB) Inc. Bureau / Suite , côte Chipman Hill PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited partnership has been filed: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a été déposée par : Reference Agent and Address Number Date Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour Canada Dominion Resources Limited Ontario C. Paul W. Smith Partnership XI 10 e étage / 10 th Floor 44, côte Chipman Hill C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A
18 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 CMP 2003 Resource Limited Partnership/ Ontario C. Paul W. Smith Societe en commandite de resources CMP e étage / 10 th Floor 44, côte Chipman Hill C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A Canada Dominion Resources Limited Ontario C. Paul W. Smith Partnership XII 10 e étage / 10 th Floor 44, côte Chipman Hill PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of change of limited partnership or extraprovincial limited partnership has been filed: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de changement de société en commandite ou de société en commandite extraprovinciale a été déposée : Principal place in Reference New Brunswick Number Date Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour Whirlpool Canada LP Saint John WCGP Nova Scotia Co. Bureau / Suite , côte Chipman Hill Office of Human Resources Bureau des ressources humaines PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS ACT OCCUPATIONAL GROUP AMENDMENTS Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour Relations Act, notice is hereby given of amendments to the following Occupational Group, effective November 28, 2005: Scientific and Professional Category, Part III Occupational Group: Nursing Definition: The provision of care of patients and assistance to medical doctors in the treatment of illness; the conduct of programs designed to prevent and reduce illness and to promote health; the provision of advice. ESTABLISH/ADD CLASSIFICATIONS Public Health Nurse Community Mental Health Nurse Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour Relations Act, notice is hereby given of amendments to the following Occupational Group, effective November 28, 2005: Operational Category, Part III Occupational Group: Institutional Services LOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES PUBLICS MODIFICATIONS CONCERNANT DES GROUPES PROFESSIONNELS Conformément à l article 24 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, avis est par les présentes donné que des modifications s appliquant au groupe suivant entrent en vigueur le 28 novembre 2005 : Catégorie scientifique et professionnelle, Partie III Groupe professionnel : Infirmières et infirmiers Définition : Dispenser des soins aux patients et aider les médecins dans le traitement des maladies; mener des programmes conçus pour prévenir et réduire les maladies et promouvoir la santé; dispenser des conseils. CLASSIFICATIONS AJOUTÉES : Infirmière-hygiéniste / infirmier-hygiéniste Infirmière / infirmier communautaire en santé mentale Conformément à l article 24 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, avis est par les présentes donné que des modifications s appliquant au groupe suivant entreront en vigueur le 28 novembre 2005 : Catégorie de l exploitation, Partie III Groupe professionnel : Services d établissement
19 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 Revised Definition: The performance and supervision of service duties in hospitals, community settings, and other patient care establishments. ESTABLISH/ADD CLASSIFICATION Human Services Counsellor Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour Relations Act, notice is hereby given of amendments to the following Occupational Group, effective November 28, 2005: Operational Category, Part III Occupational Group: Patient Care Revised Definition: The performance of patient-care duties in hospitals, community settings, and other patient care establishments. ESTABLISH/ADD CLASSIFICATION Special Education Technician Définition révisée : L exécution et la surveillance des tâches de service dans les hôpitaux, en milieux communautaires et d autres établissements de soins aux patients. CLASSIFICATION AJOUTÉE : Conseiller(ère) en intégration communautaire Conformément à l article 24 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, avis est par les présentes donné que des modifications s appliquant au groupe suivant entreront en vigueur le 28 novembre 2005 : Catégorie de l exploitation, Partie III Groupe professionnel : Soins aux patients Définition révisée : L exécution de tâches de soins aux patients dans les hôpitaux, en milieux communautaires et d autres établissements de soins aux patients. CLASSIFICATION AJOUTÉE : Spécialiste en éducation des handicapés New Brunswick Securities Commission Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick NOTICE OF RULE RULE IMPLEMENTING NATIONAL INSTRUMENT SHORT FORM PROSPECTUS DISTRIBUTIONS, FORM F3, AND AMENDMENT INSTRUMENT Minister s Consent On August 22, 2005, the Minister of Justice consented to the above rule. Summary National Instrument Short Form Prospectus Distributions ( NI ) requires all financial statements to be prepared in accordance with generally acceptable accounting principles, and audited using generally accepted auditing standards. Through NI , issuers who qualify can file a prospectus in a short form. Use of the short form prospectus reduces the time period normally required for submitting a prospectus. It streamlines the process for gaining access to the Canadian capital markets through a prospectus offering. The process has been made more flexible with the adoption of National Instrument Acceptable Accounting Principles, Auditing Standards and Reporting Currency ( NI ). Under NI , financial statements may be AVIS D UNE RÈGLE RÈGLE METTANT EN APPLICATION LA NORME CANADIENNE SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D UN PROSPECTUS SIMPLIFIÉ, FORMULE F3 ET LES MODIFICATIONS À LA NORME CANADIENNE Consentement du ministre Le 22 août 2005, le ministre de la Justice a donné son consentement à l établissement de la règle susmentionnée. Résumé La Norme canadienne sur le Placement de titres au moyen d un prospectus simplifié («NC ») exige que tous les états financiers soient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et qu ils soient vérifiés en fonction des normes de vérification généralement reconnues. La NC permet aux émetteurs admissibles de produire un prospectus simplifié. L emploi du prospectus simplifié réduit les délais normalement impartis pour la production du prospectus. Il rationalise la démarche qui donne accès aux marchés financiers canadiens pour la présentation d une offre assortie d un prospectus. L adoption de la Norme canadienne sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables («NC »), a rendu la démarche plus souple. La NC autorise la préparation d états financiers confor-
20 The Royal Gazette October 12, Gazette royale 12 octobre 2005 prepared using foreign generally accepted accounting principles and in certain circumstances may be audited using foreign generally accepted auditing standards. Form F3 - Short Form Prospectus sets out specific requirements for an issuer to provide full, true, and plain disclosure so that investors have enough information to make informed decisions regarding their investment. These requirements are in addition to general requirements under securities legislation, and include specific instructions for format. Rule also adopts the amendments of January 4, Effective Date Rule comes into force on September 12, CP also comes into force on September 12, How to Obtain a Copy The text of Rule and NI can be obtained from the following website: A paper copy of either document may be obtained from the Commission by writing, telephoning or ing: Secretary New Brunswick Securities Commission 133 Prince William Street, Suite 606 Saint John, N.B. E2L 2B5 Telephone: (506) Fax: (506) Toll Free 1 (866) (within NB only) information@nbsc-cvmnb.ca NOTICE OF RULE Pursuant to s. 20 of Regulation under the Securities Act Title Emergency Rule implementing consequential amendments to National Instrument Short Form Prospectus Distributions, and Form F3 arising from National Instrument Continuous Disclosure Obligations Summary The intent of the consequential amendments arising from the adoption of National Instrument Continuous Disclosure Obligations ( NI ) is to incorporate the requirements of mes à des principes comptables généralement reconnus de l étranger et, dans certaines circonstances, leur vérification à l aide de normes de vérification généralement reconnues de l étranger. Le formulaire F3 Prospectus simplifié énumère les exigences particulières auxquelles sont assujettis les émetteurs et qui les obligent à fournir des renseignements exhaustifs, véridiques et précis de façon à mettre à la disposition des investisseurs suffisamment d information pour leur permettre de prendre des décisions éclairées au sujet de leur placement. Ces exigences s ajoutent aux obligations générales qu imposent aux émetteurs les mesures législatives sur les valeurs mobilières et elles comprennent des instructions particulières au sujet de la présentation. La règle adopte également les amendements du 4 janvier En vigueur La règle entrent en vigueur le 12 septembre L instruction complémentaire IC entrent aussi en vigueur le 12 septembre Pour obtenir des exemplaires des documents On trouvera le texte de la règle et NC la à l adresse suivante : On peut se procurer un exemplaire sur papier de l un ou l autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission, dont en voici les coordonnées : Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 133, rue Prince William, bureau 606 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2B5 Téléphone : (506) Télécopieur : (506) Sans frais : 1 (866) (au Nouveau-Brunswick seulement) Courriel : information@nbsc-cvmnb.ca AVIS D UNE RÈGLE Sous le régime de l article 20 du Règlement de la Loi sur les valeurs mobilières Titre Règle à caractère urgent mettant en application les modifications corrélative à la Norme Canadienne sur le placement de titres au moyen d un prospectus simplifié et du formulaire de prospectus simplifié A3 découlant de la Norme canadienne sur les obligations d information continue. Résumé L intention des modifications corrélatives découlant de la Norme Canadienne sur les obligations d information continue («NC ») est l incorporation des exigences de
Crisis Lines/Emergency Numbers Lignes d écoute téléphonique/ Numéros d urgence
New Brunswick Services for Women Who Have Experienced Violence or Abuse Services au Nouveau-Brunswick pour les femmes qui ont subit de la violence ou de l abus Crisis Lines/Emergency Numbers Lignes d écoute
Plus en détailINVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001. RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre 2001
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT INVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001 LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre
Plus en détailSupport Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques
Plus en détailName Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations Règlement sur l utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu une banque ou société
Plus en détailFirst Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION First Nations Assessment Inspection Regulations Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations SOR/2007-242 DORS/2007-242 Current to September
Plus en détailListe des intervenants de Travail sécuritaire NB Septembre 2014
Alliance de la Fonction publique du Canada 287, promenade Lacewood, pièce 301 Halifax (N.-É.) B3M 3Y7 Alliance de la Fonction publique du Canada 30, rue Englehart, pièce G Dieppe (N.-B.) E1A 8H3 Ambulance
Plus en détailResident Canadian (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Resident Canadian (Insurance Companies) Regulations Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) SOR/92-284 DORS/92-284 Current to August 4, 2015 À jour
Plus en détailCheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to
Plus en détailCalculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Calculation of Interest Regulations Règlement sur le calcul des intérêts SOR/87-631 DORS/87-631 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published by the Minister
Plus en détailCODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, 2015. À jour au 30 août 2015. Last amended on December 12, 2013
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to Shared Services Canada the Control and Supervision of Certain Portions of the Federal Public Administration in each Department and Portion of the
Plus en détailBorrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurances multirisques et des sociétés d assurance
Plus en détailAppointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appointment or Deployment of Alternates Regulations Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants SOR/2012-83 DORS/2012-83 Current to August 30, 2015 À jour
Plus en détailCredit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44
Plus en détailOrder Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act Décret liant certains mandataires
Plus en détailIf the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to:
2014-10-07 Corporations Canada 9th Floor, Jean Edmonds Towers South 365 Laurier Avenue West Ottawa, Ontario K1A 0C8 Corporations Canada 9e étage, Tour Jean-Edmonds sud 365 avenue Laurier ouest Ottawa (Ontario)
Plus en détailShort-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Short-term Pooled Investment Fund Regulations Règlement sur le fonds commun de placement à court terme SOR/2006-245 DORS/2006-245 Current to September 27, 2015 À jour
Plus en détailMaterial Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Material Banking Group Percentage Regulations Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) SOR/2008-163 DORS/2008-163 Current to August 30, 2015 À jour
Plus en détailLife Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Life Companies Borrowing Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie SOR/92-277 DORS/92-277 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published
Plus en détailPractice Direction. Class Proceedings
Effective Date: 2010/07/01 Number: PD - 5 Title: Practice Direction Class Proceedings Summary: This Practice Direction describes the procedure for requesting the assignment of a judge in a proceeding under
Plus en détailLoi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,
Plus en détailPART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11
PART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11 Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest 2010-11-30 TABLE OF CONTENTS / SI: Statutory Instrument / R: Regulation / TABLE
Plus en détailRailway Operating Certificate Regulations. Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Railway Operating Certificate Regulations Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer SOR/2014-258 DORS/2014-258 Current to September 10, 2015 À jour
Plus en détailLes installations accréditées au complet en LAI dans la région Atlantique Paysagistes 16 avril, 2015
Les installations accréditées au complet en LAI dans la région Atlantique Paysagistes 16 avril, 2015 nom de l'installation Information Numéro de téléphone Personne à contacter LAI complete depuis Urban
Plus en détailLoi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement. Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement S.C. 1987, c. 27 L.C. 1987,
Plus en détailAIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES
AIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE / APPLICATION FORM Espace réservé pour l utilisation de la fondation This space reserved for foundation use
Plus en détailForm of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Form of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations Règlement sur la forme des actes relatifs à certaines successions de bénéficiaires
Plus en détailSpecial Operating Agencies Designation Regulation, amendment. Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des organismes de service spécial
THE SPECIAL OPERATING AGENCIES FINANCING AUTHORITY ACT (C.C.S.M. c. S185) Special Operating Agencies Designation Regulation, amendment LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL
Plus en détailAMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32
THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the
Plus en détailNordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. SOR/90-162 DORS/90-162 Current to June 9, 2015 À jour au
Plus en détailCONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to the Department of Supply and Services the Control and Supervision of the Government Telecommunications Agency and the Translation Bureau and Transferring
Plus en détailGeneral Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel SOR/95-43 DORS/95-43 Current to June
Plus en détailInterest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Interest Rate for Customs Purposes Regulations Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes SOR/86-1121 DORS/86-1121 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août
Plus en détailCoordonnées de l administrateur SEDI
Coordonnées de l administrateur SEDI Pour des problèmes techniques tels que : réinitialisation du mot de passe réinitialisation de la clé d accès messages d erreur Pour des questions ayant trait à l inscription
Plus en détailLOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT
ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION REGULATIONS R-085-95 In force September 30, 1995 LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES
Plus en détailDisclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de
Plus en détailBill 69 Projet de loi 69
1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 69 Projet de loi 69 An Act to amend the Business Corporations Act and the
Plus en détailRèglement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits C.R.C., c. 320 C.R.C., ch. 320 Current
Plus en détailShips Elevator Regulations. Règlement sur les ascenseurs de navires CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Ships Elevator Regulations Règlement sur les ascenseurs de navires C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482 Current to September 10, 2015 À jour au 10 septembre 2015 Last amended
Plus en détailRèglement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Bill of Rights Examination Regulations Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits C.R.C., c. 394 C.R.C., ch. 394 Current
Plus en détailOrder Assigning to the Minister of the Environment, the Administration, Management and Control of Certain Public Lands
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Assigning to the Minister of the Environment, the Administration, Management and Control of Certain Public Lands Décret attribuant au ministre de l Environnement
Plus en détailCALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009
Société en commandite Gaz Métro CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009 Taux de la contribution au Fonds vert au 1 er janvier 2009 Description Volume Coûts Taux 10³m³ 000 $ /m³ (1) (2)
Plus en détailPOLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4
POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4 Origin: Authority: Reference(s): Community Services Department Cafeteria Services and Nutrition Education Division Resolution #86-02-26-15B.1 POLICY STATEMENT All elementary
Plus en détailRèglement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation
THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel
Plus en détailAir Transportation Tax Order, 1995. Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Air Transportation Tax Order, 1995 Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien SOR/95-206 DORS/95-206 Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015 Published by
Plus en détailTERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014
NORTHWEST TERRITORIES LANDS ACT FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014 LOI SUR LES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 AMENDED BY MODIFIÉ PAR This
Plus en détailExport Permit (Steel Monitoring) Regulations. Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Export Permit (Steel Monitoring) Regulations Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) SOR/87-321 DORS/87-321 Current to August 4, 2015 À jour
Plus en détailOttawa,, 2009 Ottawa, le 2009
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 479 à 485 a, 488 b et 1021 c de la Loi sur les sociétés d assurances d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur
Plus en détailAvis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur. Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice Avis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur C.R.C., c. 41 C.R.C., ch.
Plus en détailPROJET DE LOI. An Act to Amend the Employment Standards Act. Loi modifiant la Loi sur les normes d emploi
2nd Session, 57th Legislature New Brunswick 60-61 Elizabeth II, 2011-2012 2 e session, 57 e législature Nouveau-Brunswick 60-61 Elizabeth II, 2011-2012 BILL PROJET DE LOI 7 7 An Act to Amend the Employment
Plus en détailde stabilisation financière
CHAPTER 108 CHAPITRE 108 Fiscal Stabilization Fund Act Loi sur le Fonds de stabilisation financière Table of Contents 1 Definitions eligible securities valeurs admissibles Fund Fonds Minister ministre
Plus en détailPROJET DE LOI. An Act Respecting the Revised Statutes, 2014. Loi concernant les Lois révisées de 2014
1st Session, 58th Legislature New Brunswick 63-64 Elizabeth II, 2014-2015 1 re session, 58 e législature Nouveau-Brunswick 63-64 Elizabeth II, 2014-2015 BILL PROJET DE LOI 12 12 An Act Respecting the Revised
Plus en détailSOGC Junior Members Committee. Online Elective Catalogue 2006 2007
SOGC Junior Members Committee Online Elective Catalogue 2006 2007 UPDATED MAY 2006 THIS DOCUMENT CAN ALSO BE FOUND AT: WWW.SOGC.ORG IN THE JUNIOR MEMBERS SECTION Online Elective Catalogue Page 1 of 18
Plus en détailImport Allocation Regulations. Règlement sur les autorisations d importation CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Import Allocation Regulations Règlement sur les autorisations d importation SOR/95-36 DORS/95-36 Current to May 17, 2011 À jour au 1 er 17 mai 2011 Published by the Minister
Plus en détailDisclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de compte
Plus en détailaffichage en français Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society
LIONS VILLAGE of Greater Edmonton Society affichage en français Informations sur l'employeur Nom de l'employeur *: Lions Village of Greater Edmonton Society Secteur d'activité de l'employeur *: Développement
Plus en détailPRiCEWATERHOUSGOPERS 0
PRiCEWATERHOUSGOPERS 0 PricewaterhouseCoopers Inc. 1250, boulevard Rene-Levesque Ouest Bureau 2800 Montreal (Quebec) Canada H3B 2G4 Telephone +1 (514) 205 5000 Telec. direct +1 (514) 205 5694 PROVINCE
Plus en détailBILL 13 PROJET DE LOI 13. certains droits relatifs à l approvisionnement en bois et à l aménagement forestier
1st Session, 56th 58th Legislature New Brunswick 63-6456 Elizabeth II, II, 2014-2015 2007 1 re session, 56 58 e législature Nouveau-Brunswick 63-64 56 Elizabeth II, II, 2014-2015 2007 BILL 13 PROJET DE
Plus en détailRULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5
RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative
Plus en détailINDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.
Recipient s name 5001-EN For use by the foreign tax authority CALCULATION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS Attachment to Form 5000 12816*01 INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been
Plus en détailCompléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante :
FOIRE AUX QUESTIONS COMMENT ADHÉRER? Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : 275, boul des Braves Bureau 310 Terrebonne (Qc) J6W 3H6 La
Plus en détailF1 Security Requirement Check List (SRCL)
F1 Security Requirement Check List (SRCL) Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) Cyber Protection Supply Arrangement (CPSA) Arrangement en matière d approvisionnement en cyberprotection
Plus en détailLOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5
FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5 LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY S.N.W.T. 1997,c.3 S.N.W.T. 2003,c.31 In force April 1, 2004;
Plus en détailProclamation establishing three different time zones in Nunavut, for the purposes of the definition of standard time in the Interpretation Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Proclamation establishing three different time zones in Nunavut, for the purposes of the definition of standard time in the Interpretation Act Proclamation établissant
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES page Présentation... v Avant-propos... vii Table de la jurisprudence... xvii Table des abréviations... xxxi
TABLE DES MATIÈRES Présentation........................ v Avant-propos...................... vii Table de la jurisprudence............ xvii Table des abréviations............. xxxi LOI SUR LA PROTECTION
Plus en détailPrepaid Payment Products Regulations. Règlement sur les produits de paiement prépayés CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to September 10, 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Prepaid Payment Products Regulations Règlement sur les produits de paiement prépayés SOR/2013-209 DORS/2013-209 Current to September 10, 2015 À jour au 10 septembre 2015
Plus en détail2013 IIHF WORLD WOMEN S HOCKEY CHAMPIONSHIP
2013 IIHF WORLD WOMEN S HOCKEY CHAMPIONSHIP Name Mailing address Phone Girl s Hockey Association 2011/ 12 Team Name Email TICKET PACKAGE Price/ Seat 100 Level (12 games, Lower Bowl) $ 289 200 Level (12
Plus en détailGUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR LES RÉSIDENTS PERMANENTS DU NOUVEAU BRUNSWICK
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR LES RÉSIDENTS PERMANENTS DU NOUVEAU BRUNSWICK GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR LES RÉSIDENTS PERMANENTS DU NOUVEAU BRUNSWICK Guide de référence rapide pour les résidents permanents
Plus en détailLoi sur la Semaine nationale du don de sang. National Blood Donor Week Act CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 2008, c. 4 L.C. 2008, ch.
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION National Blood Donor Week Act Loi sur la Semaine nationale du don de sang S.C. 2008, c. 4 L.C. 2008, ch. 4 Current to June 9, 2015 À jour au 9 juin 2015 Published by the
Plus en détailOrdonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Infant or Person of Unsound Mind Payment Order Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit C.R.C., c. 1600 C.R.C., ch. 1600 Current
Plus en détailAUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE
AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE PURPOSE The Audit Committee (the Committee), assists the Board of Trustees to fulfill its oversight responsibilities to the Crown, as shareholder, for the following
Plus en détailGazette royale. The Royal Gazette. Avis Important. Important Notice. Notice to Readers. Avis aux lecteurs
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick ISSN 1714-9428 Vol. 163 Wednesday, December 14, 2005 / Le mercredi 14 décembre 2005 1831 Important Notice Please
Plus en détailMise en place d un système de cabotage maritime au sud ouest de l Ocean Indien. 10 Septembre 2012
Mise en place d un système de cabotage maritime au sud ouest de l Ocean Indien 10 Septembre 2012 Les défis de la chaine de la logistique du transport maritime Danielle T.Y WONG Director Logistics Performance
Plus en détailFCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015
FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015 Early-bird registration Early-bird registration ends April
Plus en détailInput Tax Credit Information (GST/HST) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/ TVH) SOR/91-45 DORS/91-45
Plus en détailTHE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002
2-aes THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 19 [Handling
Plus en détailOFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Payment Card Networks Act Loi sur les réseaux de cartes de paiement S.C. 2010, c. 12, s. 1834 L.C. 2010, ch. 12, art. 1834 [Enacted by section 1834 of chapter 12 of the
Plus en détail86 rue Julie, Ormstown, Quebec J0S 1K0
Tel : (450) 829-4200 Fax : (450) 829-4204 Email : info@rout-am.com Contacts: Jean Côté jean@rout-am.com Jocelyn Côté jocelyn@rout-am.com Dispatch info@rout-am.com Phone: (450) 829-4200 Fax: (450) 829-4204
Plus en détailMultiple issuers. La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes :
CORPORATE EVENT NOTICE: Suspension de cotation Multiple issuers PLACE: Paris AVIS N : PAR_20141002_07393_EUR DATE: 02/10/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS La cotation des fonds mentionnés ci-dessous sera suspendue
Plus en détailCOLLEGE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS
COLLEGE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS Registration Policy on Post Secondary and Degree Programs in Early Childhood Education (Canada, other than Ontario) (Approved December 19, 2008 as amended September
Plus en détailBILL 203 PROJET DE LOI 203
Bill 203 Private Member's Bill Projet de loi 203 Projet de loi d'un député 4 th Session, 40 th Legislature, Manitoba, 63 Elizabeth II, 2014 4 e session, 40 e législature, Manitoba, 63 Elizabeth II, 2014
Plus en détailBill 204 Projet de loi 204
3RD SESSION, 37TH LEGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 3 e SESSION, 37 e LÉGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 Bill 204 Projet de loi 204 An Act to amend the Ontario Energy Board Act, 1998 to
Plus en détailAn Act to Amend the Tobacco Sales Act. Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac CHAPTER 46 CHAPITRE 46
2015 CHAPTER 46 CHAPITRE 46 An Act to Amend the Tobacco Sales Act Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac Assented to June 5, 2015 Sanctionnée le 5 juin 2015 Her Majesty, by and with the advice and
Plus en détailMaximum Capacity / Capacité maximal: 10 kg/min
Consumer and Corporate Affairs Consommation et Corporations Canada Legal Metrology Métrologie légale Supercedes Conditional Approval T Dated 1992/12/08 NOTICE OF APPROVAL Issued by statutory authority
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET LES ENSEMBLES DE RETENUE POUR ENFANTS R.R.T.N.-O. 1990, ch. M-35
MOTOR VEHICLES ACT SEAT BELT ASSEMBLY AND CHILD RESTRAINT SYSTEM REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.M-35 LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES RÈGLEMENT SUR LES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET LES ENSEMBLES DE RETENUE
Plus en détailBLUELINEA. 269.826,00 EUR composé de 1.349.130 actions de valeur nominale 0,20 EUR Date de création : 17/01/2006
CORPORATE EVENT NOTICE: Inscription par cotation directe BLUELINEA PLACE: Paris AVIS N : PAR_20120221_02921_MLI DATE: 21/02/2012 MARCHE: MARCHE LIBRE A l'initiative du membre de marché ARKEON Finance agissant
Plus en détailArchived Content. Contenu archivé
ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject
Plus en détailPaxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB
Paxton ins-20605 Net2 desktop reader USB 1 3 2 4 1 2 Desktop Reader The desktop reader is designed to sit next to the PC. It is used for adding tokens to a Net2 system and also for identifying lost cards.
Plus en détailCONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95
CONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L ADOPTION SELON LES
Plus en détailDates and deadlines 2013 2014
(Version française à la page 3) Dates and deadlines 2013 2014 The following are proposed dates and deadlines for the annual renewal cycle. Clubs in BC and Alberta, please note: you may have deadlines preceding
Plus en détailLoi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d Halifax. Halifax Relief Commission Pension Continuation Act CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Halifax Relief Pension Continuation Act Loi sur la prise en charge des prestations de la de secours d Halifax S.C. 1974-75-76, c. 88 S.C. 1974-75-76, ch. 88 Current to
Plus en détail1 400 HKD / year (Season : 21/09/2015 01/06/2016)
* Please refer to the Grade reference table at the end of this document Inscription en ligne uniquement via votre espace parent, à partir du samedi 12 septembre 2015 à 10h00 Enrolment process will only
Plus en détailBill 164 Projet de loi 164
2ND SESSION, 38TH LEGISLATURE, ONTARIO 55 ELIZABETH II, 2006 2 e SESSION, 38 e LÉGISLATURE, ONTARIO 55 ELIZABETH II, 2006 Bill 164 Projet de loi 164 An Act to amend the Consumer Protection Act, 2002, the
Plus en détailApplication Form/ Formulaire de demande
Application Form/ Formulaire de demande Ecosystem Approaches to Health: Summer Workshop and Field school Approches écosystémiques de la santé: Atelier intensif et stage d été Please submit your application
Plus en détailFiled December 22, 2000
NEW BRUNSWICK REGULATION 2000-64 under the SPECIAL PAYMENT TO CERTAIN DEPENDENT SPOUSES OF DECEASED WORKERS ACT (O.C. 2000-604) Regulation Outline Filed December 22, 2000 Citation..........................................
Plus en détailVILLE DE MONTRÉAL CITY OF MONTREAL. Arrondissement Kirkland Borough
VILLE DE MONTRÉAL CITY OF MONTREAL Arrondissement Kirkland Borough ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D=ARRONDISSEMENT DE KIRKLAND, LE LUNDI 5 JUILLET 2004, À 20H00. REGULAR MEETING OF THE KIRKLAND BOROUGH
Plus en détailBill 163 Projet de loi 163
2ND SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 60 ELIZABETH II, 2011 2 e SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 60 ELIZABETH II, 2011 Bill 163 Projet de loi 163 (Chapter 8 Statutes of Ontario, 2011) (Chapitre 8 Lois
Plus en détailLE FORMAT DES RAPPORTS DU PERSONNEL DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMENAGEMENT FORMAT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION STAFF REPORTS
FORMAT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION STAFF REPORTS LE FORMAT DES RAPPORTS DU PERSONNEL DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMENAGEMENT A Guideline on the Format of District Planning Commission Staff Reports
Plus en détailCI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES
CI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces exigent les courtiers et les conseillers à n agir qu en conformité avec les règles particulières de communication
Plus en détailAPPENDIX 6 BONUS RING FORMAT
#4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor
Plus en détailCONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS. 1 In this Act,
CONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS Definitions 1 In this Act, Chief Legislative Counsel means that member of the public service appointed to this position
Plus en détail