MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 84673 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. C N 1765 13 juillet 2012 1798 AOG Energy Fund...84714 3 C Investments & Partners S.A.... 84714 Atelier d'architecture Beng...84688 Bayerische Entwicklung S.P.F.... 84693 Bryni Luxembourg S.à r.l.... 84704 Clerc...84708 Colada AcquiCo S.à r.l....84691 Compagnie Luxembourgeoise d'expertise et de Révision Comptable...84714 Compo AcquiCo S.à r.l.... 84691 Compo Co-Invest S.à r.l.... 84709 Discovery S.A....84694 Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois...84695 Finantel S.A., SPF... 84694 Grant Thornton Révision et Conseils S.A....84715 Kingsbridge Finance S.à r.l....84715 L'Atelier d'architecture Engel, Bidaine, Goedert, Noury... 84688 Lillington International S.A.... 84694 Marita Spf S.A.... 84699 Melodium S.A....84702 Memphis Engineering Corporation S.A....84718 Memphis Engineering Corporation S.A....84718 Merym S.A.... 84702 M.F.L. S.A.... 84700 Miplaka S.A. - SPF...84719 Monitor-IT S.A....84702 Najis Real Estate S.A.... 84719 Napos Trading Company S.A.... 84720 NasyaJet S.A....84719 SOMMAIRE New European Corporation SA...84720 New Pearl S.à r.l....84718 NGF S.A.... 84720 Northridge S.à r.l.... 84719 Novator Credit Luxembourg S.à r.l....84704 Nsearch S.A.... 84705 Nutrisearch S.A....84707 Orcade S.A....84706 Pa.Fi. France... 84719 Picard Bondco...84708 POFI Engineering S.A.... 84714 PP Group S.A....84703 PP Group S.A....84704 Prolifica International S.A.... 84713 Prolifica International S.A.... 84709 Property Partners Residential...84720 Property Partners S.A....84718 QGOG Constellation S.A.... 84703 Setas International SPF S.A....84694 Shepherd Capital...84713 Succursale Gaz Métro International...84700 Succursale Gaz Métro International...84715 Sundsval Invest S.A....84693 Sunflower S.à r.l.... 84708 Symbiotics SICAV (Lux.)...84674 The Malaspinian Fund SCA SICAV-FIS...84709 Tishman Speyer Management (TSEC) S.à r.l....84707 Transalliance Europe...84711 Triton III MidCo 11 S.à r.l....84709 Victoria Trading S.A., SPF... 84713 Way LuxCo S.à r.l....84713
84674 Symbiotics SICAV (Lux.), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'investissement Spécialisé. Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer. R.C.S. Luxembourg B 169.830. STATUTES In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of June. Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg). There appeared: Symbiotics SA Information, Consulting & Services, a société anoyme incorporated and existing under the laws of Switzerland having its registered office at 75 rue de Lyon, Geneva, Switzerland, represented by Céline Wilmet, juriste, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy given on 25 June 2012. The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities. This appearing person, in her capacity, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a "société anonyme" named "Symbiotics SICAV (Lux.)" and qualifying as a "société d'investissement à capital variable fonds d'investissement spécialisé" ("SICAV-FIS") which it intends to incorporate in Luxembourg. Title I. Denomination, Duration, Object, Registered office Art. 1. Name. There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares of the Company hereafter issued, a company in the form of a société anonyme (public limited company) qualifying as a société d'investissement à capital variable fonds d'investissement spécialisé (investment company with variable capital specialised investment fund) under the name of Symbiotics SICAV (Lux.) (the "Company"). The Company shall enter into an investment management agreement with one or more companies of, or affiliated to, the Symbiotics group (hereafter collectively the "Manager"), under which agreement such Manager will advise upon and manage the portfolio investments of the Company. In the event of the termination of the investment management agreement in any manner whatsoever, the Company will at the request of the Manager change its name forthwith to a not including the word "Symbiotics" in any part thereof, and no further usage of the "Symbiotics" name or brand shall be used by the Company without the express consent of the entity holding the intellectual rights over the name "Symbiotics" (the "Symbiotics Owner"). The Company shall indemnify the Symbiotics Owner and hold it harmless from and against all liabilities, damages, losses, claims, causes of action, costs, expenses (including, without limitation, legal fees and court costs) and/or proceedings (including without limitation indirect, consequential, special, incidental, or punitive damages arising out of or in connection with the use of the name "Symbiotics" in any way from the effective termination date of the investment management agreement functions of the appointed Manager). Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles"). Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in any kind of permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the "Law") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law. Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg. Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (the "Board"). The Board is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of Luxembourg and, to the extent that it is allowed by the law, to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg. The registered office may also be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for any amendment to the Articles of Incorporation. In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military events have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
84675 Title II. Share capital - Shares - Net asse value Art. 5. Share Capital. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the net assets of the Company as defined in Article 12 hereof. The initial subscribed capital is forty-two thousand USD (USD 42,000) divided into forty-two (42) fully paid up shares which may be entirely redeemed at their initial value by the launch date of the first sub-fund. The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by Luxembourg law and must be reached within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under the Law. The Board may, at any time as it deems appropriate decide to create one or more compartments or sub-funds within the meaning of article 71(1) of the Law, (each such compartment or sub-fund, a "Sub-Fund"). The Company constitutes a single legal entity, but the assets of each Sub-Fund shall be invested for the exclusive benefit of the shareholders of the corresponding Sub-Fund and the assets of a specific Sub-Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Sub-Fund. The shares to be issued in a Sub-Fund may, as the Board shall determine, be of one or more different classes (each such class, a "Class"), the features, terms and conditions of which shall be established by the Board. For the purposes of these Articles, any reference hereinafter to a "Class" shall also mean a reference to a "Sub-Class", unless the context otherwise requires. The Board may create each Sub-Fund for an unlimited or a limited period of time. The proceeds from the issue of shares of any Class within a Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 17 hereof in securities of any kind or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities or assets or with such other specific features, as the Board shall from time to time determine in respect of the relevant Sub-Fund. For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class shall, if not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes. The general meeting of shareholders of a Sub-Fund or Class, deciding with simple majority, or the Board may consolidate ("reverse split") or split the shares of such Sub-Fund or Class. The Company shall in any event issue Class S shares. Class S shares shall be issued to entities of Symbiotics group (as defined in the sales documents of the Company). By derogation to article 30 hereof, any change to paragraphs 9 and 10 of this Article are subject to the consent of all Class S shareholders. Art. 6. Issue of shares. The Board is authorised without limitation to issue further partly or fully paid shares, as determined by the Board, at any time, in accordance with the procedures and subject to the terms and conditions determined by the Board and disclosed in the sales documents, without reserving to the existing shareholders preferential or pre-emptive rights to subscription of the shares to be issued. Investors will either subscribe for a determined number of shares or for a determined amount, as determined by the Board and disclosed in the sales documents or subscription form of the Company. Any reference to a subscription to shares shall be construed accordingly. Investors shall have either to commit to subscribe to shares or may directly subscribe to shares, as determined by the Board and disclosed in the sales documents. In case the Board decides that investors have to commit to subscribe shares, investors will be required to execute a subscription agreement and indicate therein their total committed capital (the "Commitment" or "Commitments"), subject to any minimum Commitment as may be decided by the Board. The procedures relating to Commitments and drawdown of the Commitments will be disclosed in the sales documents and the subscription agreement. If at any time an investor or shareholder fails to honour its Commitment through the full payment of the subscription price within the timeframe decided by the Board (a "Defaulting Investor") and referred to in the sales document, the Board has the authority, in addition to any legal remedies, to take vis-à-vis such Defaulting Investor one or several of the measures as disclosed in the sales documents. Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the issue price shall be based on to the Net Asset Value for the relevant Class, as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, plus all applicable subscription fees and charges, as the sales documents may provide. The Board may also make any adjustment to the issue price as it may consider appropriate to ensure fairness between the shareholders. For the avoidance of doubt, the issue price may among others also be based at any time on the initial subscription price for the relevant Sub-Fund or Class, plus any applicable subscription fees and charges as the sales documents may provide. Shares of the Company are restricted to institutional investors, professional investors or any other well-informed investors (investisseurs avertis) within the meaning of the Law ("Eligible Investors"). The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for such new shares, remaining always within the limits imposed by the Law.
84676 The Board is further authorised to determine the conditions of any such issue and to make any such issue subject to payment at the time of issue of the shares. The issue of shares shall be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 11 hereof. The Board may decide to issue shares against contribution in kind in accordance with Luxembourg law. To the extent required by the applicable laws and regulations, the contributed assets shall be valued in a report issued by the auditor of the Company. Any costs incurred in connection with a contribution in kind shall be borne by the relevant shareholder, unless the Board considers that the subscription in kind is in the interests of the Company in which case such costs may be borne in all or in part by the Company. The Board reserves the right to accept or refuse any application in whole or in part in its entire discretion and without having to give the reasons thereof. The Boars may also, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who holds shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board, the other shareholders and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to any such holding in circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or had failed to notify the Company of its loss of such status. Art. 7. Form of shares. The Company will in principle issue shares in registered form only. If and to the extent permitted, and under the conditions provided for, by law, the Board may at its discretion decide to issue, in addition to shares in registered form, shares in dematerialised form. Under the same conditions, holders of registered shares may also request the conversion of their shares into dematerialised shares. The costs resulting from the conversion of registered shares at the request of their holders will be borne by the latter unless the Board decides at its discretion that all or part of these costs must be borne by the Company. All issued registered shares of the Company other than dematerialised shares (if issued) shall be inscribed in the register of shareholders (the "Register"), which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefor by the Company. The Register shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile as notified to the Company and the number and Class(es) of shares held by him. Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register. In the event of joint holders of shares, only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only. In the event that a shareholder does not provide an address, or such notices and announcements are returned as undeliverable to an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or any other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by the shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register by means of a written notification to the Company at its registered office, or at any other address as may be set by the Company from time to time. The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the Register as full owner of the shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such shares to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which he might properly have to request a change in the registration of his shares. Holders of dematerialised shares must provide, or must ensure that registrar agents shall provide, the Company with information for identification purposes of the holders of such shares in accordance with applicable laws. If on a specific request of the Company, the holder of dematerialised shares does not furnish the requested information, or furnishes incomplete or erroneous information within a time period provided for by law or determined by the Board of Directors at its discretion, the Board of Directors may decide to suspend voting rights attached to all or part of the dematerialised shares held by the relevant person until satisfactory information is received. The Company will recognise only one holder per share. In the event of joint ownership the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share(s) until one person has been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company. In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion. Fractions of registered shares up to the number of decimal places to be decided by the Board will be issued if so decided by the Board. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets and any distributions attributable to the relevant Class on a pro rata basis. Fractions of dematerialised shares, if any, may also be issued at the discretion of the Board.
84677 The Company shall decide whether share certificates shall be delivered to the shareholders and under which conditions or whether the shareholders shall receive a written confirmation of their shareholding. Any share certificates shall be signed by two (2) directors or by a director and an official duly authorised by the Board for such purpose. Signatures of the directors may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature of the authorised official shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in any such form as the Board may from time to time determine. Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register to be made by the Company upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such shares, to the Company along with appropriate document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee and any such other documentation as the Company may require. The transfer of dematerialised shares (if issued) shall be made in accordance with applicable laws. The Company will refuse to give effect to any transfer of shares and refuse any transfer of shares to be entered in the Register in circumstances where such a transfer would result in shares being held by any person not qualifying as an Eligible Investor. Art. 8. Destruction of share certificates. If share certificates are issued and if any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issue of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void. The Company may elect to charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issue and registration thereof, or in connection with the annulment of the original share certificate. Art. 9. Restrictions on the ownership of shares. The Board shall have power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person not qualifying as an Eligible Investor, (b) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority or (c) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability or taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered. More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body. For such purposes the Company may: a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such a registry would or might result in the share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the Company; b) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of that shareholder's share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Company; c) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company; and d) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion of the shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, (i) direct such shareholder to (a) transfer his shares to a person qualified to own such shares, or (b) request the Company to redeem his shares, or (ii) compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner: 1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") upon the shareholder holding such shares or appearing in the Register as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon the shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to him at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if issued) representing the shares specified in the Redemption Notice. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice, the shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or owned by him shall be cancelled; 2) The price at which the shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the "Redemption Price") shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Company of the relevant Class, determined in accordance with Article 12 hereof, less any service charge (if any). Where it appears that, due to the situation of the shareholder, payment of the redemption price by the Company, any of its agents and/or any other intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the Redemption Price an amount sufficient to cover such potential liability until such time that the shareholder provides the Company, any of its agents and/or any
84678 other intermediary with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case the amount may no longer be claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by confidentiality rules; 3) Payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency of denomination for the relevant Class and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to that person but only, if a share certificate shall have been issued, upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in the notice. Upon deposit of the price as aforesaid no person interested in the shares specified in the Redemption Notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from the bank as aforesaid. 4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was other than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such a case the said powers were exercised by the Company in good faith. Art. 10. Redemption and Conversion of Shares. As is more specifically prescribed hereinbelow the Company has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law. Unless otherwise provided for a specific Sub-Fund or Class in the sales documents, any shareholder may request the redemption of all or part of his/her/its shares by the Company under the terms, conditions and limits set forth by the Board in the sales documents and within the limits provided by law and these Articles. Any redemption request must be filed by the shareholder in written form, subject to the conditions set out in the sales documents of the Company, at the registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued). Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the redemption price shall be based on the Net Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof less all applicable redemption fees and charges as the sales documents may provide. This price may be rounded up or down, as the Board may determine, and such rounding will accrue to the benefit of the Company, as the case may be. The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the Board provided that the share certificates, if issued, and any requested documents have been received by the Company, subject to Article 11 hereof. The Board may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any specific Class or Classes. The specific period for payment of the redemption proceeds of any Class of the Company and any applicable notice period as well as the circumstances of its application will be published in the sales documents relating to the sale of such shares. The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto. The Board may (subject to the principle of equal treatment of shareholders and, if required by the applicable laws and regulations, the consent of the shareholder(s) concerned) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the applicable redemption price attributable to the shares to be redeemed as described in the sales documents. To the extent required by the applicable laws and regulations, any such redemption will be subject to a special audit report by the auditor of the Company. The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, if any, will have to be borne by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless the Board considers that the redemption in kind is in the interests of the Company or made to protect the interests of the Company. Any request for redemption is revocable under the conditions determined by the Board and disclosed in the sales documents, if any, and in the event of suspension of redemption pursuant to Article 11 hereof or a deferral of the redemption request as provided for below. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Day after the end of the suspension. Unless otherwise provided for in the sales documents, any shareholder may request conversion of whole or part of his shares of one Class of a Sub-Fund into shares of another Class of that or another Sub-Fund or the same Class of another Sub-Fund at the respective Net Asset Values of the shares of the relevant Classes under the terms, conditions and limits set forth by the Board in the sales documents. The Board may notably impose restrictions between Classes of shares as disclosed in the sales documents as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversions subject to payment of a charge as specified in the sales documents. The conditions relating to the exercise of such right by the Board will (if any) be detailed in the sales documents of the Company. The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has been fully settled by the shareholder.
84679 If with respect to any given Valuation Day, redemption requests and conversion requests exceed a certain level determined by the Board and set forth in the sales documents, the Board may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the Board considers to be in the best interests of the relevant Sub-Fund or Class and of the Company. The Board may refuse redemptions for an amount less than the minimum redemption amount as determined by the Board and disclosed in the sales documents, if any, or any other amount the Board should determine at its sole discretion. If a redemption or conversion were to reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one Sub- Fund or Class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time and publish in the sales documents of the Company, then that shareholder may be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of that Sub-Fund or Class. The Board may, in its absolute discretion, compulsory redeem or convert any holding with a value of less than the minimum holding amount under the conditions disclosed in the sales documents of the Company. In exceptional circumstances relating to a lack of liquidity of certain investments made by certain Sub-Funds and the related difficulties in determining the Net Asset Value of the Shares of certain Sub-Funds, the treatment of redemption requests may be deferred and/or the issue, redemptions and conversions of Shares suspended by the Board. In the same circumstances, the Board may consider the creation of side-pockets via any means and to the largest extent authorised pursuant to applicable Luxembourg laws and regulations. In addition to the foregoing, the Board may decide to temporarily suspend the redemption of shares if exceptional circumstances as set forth in Article 11, so warrant. The Board or any duly appointed agent may further decide to compulsorily redeem shares (i) the subscription of which would not be made in accordance with the sales documents of the Company or (ii) whose wired subscriptions amounts would be insufficient to cover the relevant subscription price (including, for the avoidance of doubt, any applicable subscription charge). Such redemption will be carried out under the most favourable conditions for the Company, including among other the possibility for the Company to keep the difference between the redemption price and the subscription price when the latter is lower than the former or claim to the relevant investor that difference when the latter is higher than the former. Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled. Art. 11. Frequency of the calculation of the NAV. The Net Asset Value of shares shall, for the purpose of the redemption, conversion or issue of shares, be determined by the Company or any agent appointed thereto, under the responsibility of the Board, from time to time, but in no event less than once per year, as the Board may determine (every day or time for determination of net asset value being referred to herein as a "Valuation Day"). The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of one or more Sub-Fund(s) and consequently the issue, redemption and conversion of shares of such Sub-Fund(s), it being understood that where the context so requires "Sub-Fund" may also be read as "Class": (a) during any period when any one of the stock exchanges or other principal markets on which a substantial portion of the assets of the Company attributable to such Sub-Fund(s), from time to time, is quoted or dealt in is closed (otherwise than for ordinary holidays) or during which dealings therein are restricted or suspended provided that such restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund(s) quoted thereon; or (b) during any period when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the control, responsibility and power of the Board, or the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Board, disposal or valuation of the assets held by the Company attributable to such Sub-Fund(s) is not reasonably practicable without this being detrimental to the interests of Shareholders, or if in the opinion of the Board, the issue and, if applicable, redemption prices cannot fairly be calculated; or (c) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value of any of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund(s) or the current prices or values on any stock exchanges or other markets in respect of the assets attributable to such Sub-Fund(s); or (d) during any period when dealing the units/shares of an investment vehicle in which the concerned Sub-Fund(s) may be invested are restricted or suspended; or, more generally, during any period when remittance of monies which will or may be involved in the realisation of, or in the payment for any of the concerned Sub-Fund(s)' investments is not possible; or (e) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of Shares of such Sub-Fund(s) or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of Shares of the Company cannot, in the opinion of the Board, be effected at normal exchange rates; or (f) from the time of publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose of winding up the Company or any Sub-Fund(s), or merging the Company or any SubFund(s), or informing the shareholders of the decision of the Board to terminate or merge any Sub-Fund(s); or
84680 (g) when for any other reason, the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund cannot be promptly or accurately ascertained; or (h) during any other circumstance where a failure to do so might result in the Company, any of its Sub-Funds or its shareholders incurring any liability, pecuniary disadvantages or any other detriment which the Company the Sub-Fund or its shareholders might so otherwise not have suffered; or (i) during any period when in the opinion of the Board there exist circumstances outside of the control of the Company where it would be impracticable or unfair towards the Shareholders to continue dealing in Shares of the concerned Sub- Fund(s) or Class(es) of the Company. Notice of the suspension shall be given by the Company to all the shareholders affected, i.e. having made an application for subscription, redemption or conversion of shares for which the determination of the Net Asset Value has been suspended. In case of suspension of the calculation of the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund or Class shareholders may give notice that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, the application will be dealt with on the first applicable Valuation Day following the end of the period of suspension. Art. 12. Valuation regulations. A Net Asset Value may be calculated for all or some Classes/Sub-Classes of shares at the frequency provided for in the sales documents of the Company. To the extent such a calculation is made, the principles described in this Article 12 shall apply. The Net Asset Value of shares of each Class within each Sub-Fund (the "Net Asset Value") shall be expressed in the reference currency of the relevant Class (and/or in any other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per share figure and shall be determined as at any Valuation Day by dividing the value of the total assets of the Sub- Fund properly allocated to that Class less the liabilities of the Sub-Fund properly allocated to that Class by the total number of Shares of that Class outstanding as at any Valuation Day, in accordance with the rules set forth below. The Net Asset Value per share may be rounded up or down as the Board shall determine. The Net Asset Value per share will be calculated and available not later than the date set forth in the sales documents. A. If, since the time of determination of the Net Asset Value as at the relevant Valuation Day, there has been a substantial change in the valuation of the investments attributable to the relevant Sub-Fund, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and of the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation until any subscription, redemption or conversion has been processed on the basis of the Net Asset Value so determined. The assets of the Company shall be deemed to include (without limitation): (1) All cash at hand and on deposit, including interest accrued thereon. (2) All bills and demand notes payable and accounts receivable (including the proceeds of securities sold but not delivered). (3) All bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company. (4) All stock dividends, cash dividends and cash distributions declared receivable by the Company to the extent that information thereon is reasonably available to the Company. (5) All interest accrued on any interest-bearing asset owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of that asset. (6) The preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company, insofar as they have not been amortised. (7) The liquidating value of all futures and forward contracts and all call and put options in which the Company has an open position. (8) All other assets of any kind and nature, including prepaid expenses. The value of such assets shall be determined as follows: (1) Debt instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other regulated market that operates regularly, is recognised and open to the public and will be valued at the nominal value plus accrued interest. The value will be adjusted, if appropriate, to reflect e.g. major fluctuations in interest rates in the relevant markets or the appraisal of the Board or any of its agents on the creditworthiness of the relevant debt instrument. The Board will use its best endeavours to continually assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that debt instruments will be valued at their fair value as determined in good faith by the Board. If the Board believes that a deviation from this method of valuation may result in material dilution or other unfair results to Shareholders, the Board will take such corrective action, if any, as it deems appropriate to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results. (2) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable (including any rebates on fees and expenses payable by any investment fund), prepaid expenses, cash dividends declared and interest accrued, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making any discount as the Board may consider appropriate to reflect the true value thereof.
84681 (3) The value of securities (including shares or units of closedended investment funds) which are quoted, traded or dealt in on any stock exchange shall be based on the last closing prices or, if appropriate, on the average price on the stock exchange which is normally the principal market of such securities, and each security traded on any other regulated market shall be valued in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities. (4) The valuation of private equity investments will be based on the International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines issued by the EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association), the BVCA (British Venture Capital Association) and the AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital) in March 2005, or any subsequent update of such guidelines, and is conducted with prudence and in good faith. (5) For other non-quoted securities or securities not traded or dealt in on any stock exchange or other regulated market as well as quoted or nonquoted securities on any such other market for which no valuation price is available, or securities for which the quoted prices are, in the opinion of the Board, not representative of the fair value, the value thereof shall be determined prudently and in good faith by the Board on the basis of foreseeable sale prices. (6) Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an amortised cost basis. (7) The liquidating value of futures, spot, forward, cross-currency swap or options contracts not traded on exchanges or on other regulated markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, spot, forward or options contracts traded on exchanges or on other regulated markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, spot, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board may deem fair and reasonable. However, foreign exchange derivative instruments ( FX derivative(s) ), such as but not limited to foreign exchange forward, future ( FX future ) and cross-currency swap ( Swap ) contracts, which are entered in by the Company for the sole purpose of hedging a non regularly quoted or an illiquid debt investment, denominated in currency different from the reference currency of the relevant Sub-Fund and which are linked in notional, spot exchange rates, interest rates, maturities and other terms to that investment may, at the discretion of the Board, be valued considering the economic substance of the transaction. Rather than valuing separately the debt instrument in the original currencies and the related FX derivative contracts, the debt and the related contract may be amalgamated as if it was a synthetic debt instruments denominated in the reference currency of the relevant Sub-Fund. Such derivative contracts may be valued as at any Valuation Day using the spot exchange rate on the principal and accrued interest amounts of the related debt instrument. Such valuation approach may be changed if a credit risk materializes in the form of impairment. The part of the FX derivative notional then exceeding the valuation of the underlying debt instrument may be valued using a marked to market approach and any difference between (i) the forward rate at which the FX derivative was contracted and (ii) the spot rate at which the debt instrument was disbursed, may be amortized over the period until expiration of the debt instrument and recognized as interest income or expense. In the case where the underlying debt investment is sold before maturity, the net gain or loss realized after the unwinding of the related FX derivative transaction may be fully accounted as interest income or expense. (8) Investments in open-ended investment funds will be taken at their latest official net assets values or at their latest unofficial net asset values (i.e. which are not generally used for the purposes of subscription and redemption of shares of the underlying investment funds) as provided by the relevant administrators or investment managers if more recent than their official net asset values and for which the Board, assisted by the Administrative Agent, has sufficient assurance that the valuation method used by the relevant administrator for said unofficial net asset values is coherent as compared to the official one. If events have occurred which may have resulted in a material change of the net asset value of such shares or units in other investment funds since the day on which the latest official net asset value was calculated, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the Board, such change of value. (9) All other securities and assets will be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board. The Board, or any appointed agent, at its discretion, may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such a valuation better reflects the fair value and is in accordance with good accounting practice. For the purpose of determining the value of the Company's assets, the administrative agent, having due regard to the standard of care and due diligence in this respect, may, when calculating the Net Asset Value, completely and exclusively rely, unless there is manifest error or negligence on its part, upon the valuations provided (i) by various pricing sources available on the market such as pricing agencies or fund administrators, (ii) by brokers, or (iii) by a specialist duly authorised to that effect by the Board. Finally, in cases where no prices are found or when the valuation may not correctly be assessed, the administrative agent may rely upon the valuation of the Board. In circumstances where (i) one or more pricing sources fail(s) to provide valuations to the administrative agent, which could have a significant impact on the Net Asset Value, or where (ii) the value of any asset(s) may not be determined as rapidly and accurately as required, the administrative agent is authorised to postpone the Net Asset Value calculation
84682 and as a result may be unable to determine subscription, redemption and conversion prices. The Board shall be informed immediately by the administrative agent should the situation arise. The Board may then decide to suspend the calculation of the Net Asset Value. For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 12 are rules for determining Net Asset Value per Share and are not intended to affect the treatment for accounting or legal purposes of the assets and liabilities of the Company or any securities issued by the Company. B. The liabilities of the Company shall be deemed to include (without limitation): (1) All loans, bills and accounts payable. (2) All accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans). (3) All accrued or payable fees and expenses (including administrative expenses, management fees, including incentive fees, custodian fees, central administration agent's fees and registrar and transfer agent's fees). (4) All known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments in cash or in kind, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company. (5) An appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as an amount (if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company. (6) All other liabilities of the Company, of whatever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting principles. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the Company, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amendments to the constitutional documents, all translation costs, fees and expenses payable to the investment manager(s)/ advisor(s), including performance fees, if any, the custodian and its correspondent agents, the administrative agent, domiciliary and corporate agent, the registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, any distributor or other agents and employees of the Company, as well as any permanent representatives of the Company in countries where it is subject to registration, the costs and expenses for legal, accounting and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any government agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, the cost of printing share certificates, if any, and the costs of any reports to the shareholders, expenses incurred in determining the Company's Net Asset Value, the cost of convening and holding shareholders' and directors' meetings, reasonable travelling expenses of directors, directors' fees, all taxes and duties charged by governmental or similar authorities and stock exchanges, the costs of publishing the issue and repurchase prices as well as any other operating costs, including the costs of buying and selling assets, finder fees, financial, banking and brokerage expenses and all other administrative costs as well as interest, bank charges, currency conversion costs, postage, telephone and telex, insurance costs, including insurance costs for the directors, employees and agents of the Company, costs and expenses related to legal, notarial and /or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings, involving, directly or indirectly, the Company, directors, employees and agents of the Company as well as legal, as far as is permitted by law, notarial and/or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings, related, directly or indirectly to former or existing shareholders. In assessing the amount of such liabilities, the Company shall take into account pro rata temporis any expenses or other costs, administrative and other, that occur regularly or periodically. C. A separate pool of assets and liabilities in respect of each Sub-Fund shall be established in the following manner: (1) Proceeds resulting from the issue of shares in different Sub-Funds shall be allocated in the Company's books to the pool of assets of that Sub-Fund and the assets, liabilities, commitments, revenues and expenses relating to that Sub- Fund shall be allocated to the corresponding pool in compliance with the provisions below. (2) When an income or asset is derived from another asset, the income or asset will be recorded in the Company's books under the same Sub-Fund holding the asset from which it derived, and, on each revaluation of the asset, the increase or decrease in value shall be allocated to the corresponding Sub-Fund. (3) When the Company incurs a liability attributable to a specific asset in a given pool of assets or to a transaction performed in relation to the assets of a given Sub-Fund, this liability shall be allocated to that Sub-Fund. (4) If an asset or a liability of the Company cannot be allocated to a given Sub-Fund, this asset or liability shall be allocated to all Sub-Funds pro rata to their respective Net Asset Values or in any other manner the directors may decide in good faith. (5) Following a dividend distribution to shareholders of a Sub-Fund, the Net Asset Value of that Sub-Fund shall be reduced by the amount of such distribution. If two or more Classes have been created within a Sub-Fund, the allocation rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to those Classes. All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.
84683 In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken by the Board or by any agent which the Board may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders. D. For the purpose of valuation under this Article: (a) each of the Company's shares subject to a redemption request shall be considered as a share issued and outstanding until the close of business on the Valuation Day on which it is redeemed and its price shall be considered a liability of the Company from the close of business on that Valuation Day until the price has been paid. (b) each share to be issued by the Company in accordance with subscription forms received shall be considered as issued from the close of business on the Valuation Day of its issue. (c) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference currency in which the Net Asset Value per share of the relevant Class is calculated shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant Class; and (d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company on such Valuation Day to the extent practicable. Art. 13. Co-management. The Board may authorise investment and management of all or any part of the portfolio of assets established for two or more Sub-Funds on a pooled basis, or of all or any part of the portfolio of assets of the Company on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg collective investment schemes, all subject to compliance with applicable regulations. Title III. Administration and Supervision Art. 14. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members; members of the Board need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period determined by the meeting in compliance with the law. Class S shareholders are entitled to propose a list of candidates to the general meeting of shareholders out of which a majority of the directors appointed by the general meeting of shareholders to the Board must be chosen (the "Class S Directors"). There shall be in any case a majority of Class S Directors at the Board at all times. Shareholders may not express their votes for a number of candidates exceeding the number of director positions to be filled. The only economic right attached to Class S shares is the right to receive reimbursement of the initial contribution of the Class S shareholder (as further detailed under section Subscription and Payment below) either upon request of the redemption of its shares or at the liquidation of the relevant Sub-Fund (or of the Company). Any person who wants to propose a candidate for the position of directors of the Company to the general meeting of shareholders, must present such candidate to the Company in writing at least three weeks prior to the date of such general meeting. Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting, provided however that if a Class S Director is removed and that the number of remaining Class S Directors would no longer constitute the majority of the Board, the remaining directors must call for an extraordinary general meeting without delay in order for a new Class S Director to be appointed in his/her/its place and the new Class S Director appointed by the general meeting of shareholders must be chosen from the candidates on the list presented by the Class S shareholders]. In the event of a vacancy in the office of a director appointed by a general meeting of shareholders, because of death, retirement or otherwise, the remaining directors so appointed may elect, by majority vote, a Director to fill the vacancy until the next general meeting of shareholders. For the avoidance of doubt, a vacancy in the office of a Class S Director must be filled with a new Class S Director. By derogation to article 30 hereof, any change to paragraphs 3 to 7 of Article 14 is subject to the consent of all Class S shareholders. Art. 15. Meeting of the Board. The Board will choose a chairman from among its members, and may choose one or more vice-chairmen from among its members. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by the Chairman or by any two (2) directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for the meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram, telex, telefax or any other electronic means capable of evidencing such a waiver of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
84684 Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, telefax message or any electronic means capable of evidencing such an appointment, another Director as his proxy. Any Director may attend a meeting of the Board using teleconference or videoconference means. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex, telefax message or any other electronic means capable of evidencing that vote. The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board. The Board can deliberate or act validly only if at least two directors are present or represented by another Director as proxy at a meeting of the Board. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at that meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote. Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one or several documents in writing signed by all the directors or by telex, cable, telegram, telefax message or by telephone provided that in any such latter event that vote is confirmed in writing. The Board may, from time to time, appoint officers of the Company, including a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board. The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of any such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are directors and that no meeting of the committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are directors of the Company. Art. 16. Minutes. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, as the case may be, pro tempore who presided at the meeting or by any two directors. Copies or extracts of any such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors. Art. 17. Powers of the Board. The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of management and business affairs of the Company. If permitted by and at the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund may, to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Company, invest in one or more other Sub-Funds. The Board shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company. Art. 18. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of any such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business, shall not, by reason of his connection and/or relationship with that other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to any such contract or other business. In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted for approval to the Board conflicting with that of the Company, that Director or officer shall make known to the Board such conflict and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction shall be reported to the next meeting of shareholders. The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board or by the single director relates to current operations entered into under normal conditions. The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, provided that this personal interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations. Art. 19. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Any such person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall
84685 be finally adjudged in any action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, any indemnity shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit any such breach of duty. The foregoing right of indemnity shall not exclude other rights to which he may be entitled. Art. 20. Signatory power. The Company will be bound by the joint signature of any two directors or by the joint or single signature(s) of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the Board. Art. 21. Auditor. The Company shall appoint a réviseur d'entreprises agréé (approved statutory auditor) who shall carry out the duties prescribed by of the Law. The auditor shall be elected by the general meeting of the shareholders for a period determined by such meeting and until its successor is elected. Title IV. General meetings - Accounting year distribution Art. 22. General meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the Class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. Art. 23. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the twenty-eighth day of the month of September at 2.30 p.m. (Luxembourg time). If this day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time and place are to be decided by the Board. Other meetings of shareholders or of holders of shares of any specific Sub-Fund or Class may be held at any such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. Art. 24. Quorum and Voting. The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein. Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined according to the shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to his shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date. In case of dematerialised shares (if issued) the right of a holder of such shares to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to such shares will be determined by reference to the shares held by this holder as at the time and date provided for by Luxembourg laws and regulations. Each share of whatever Class and regardless of the Net Asset Value per share within that Class, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex, telefax message or any other electronic means capable of evidencing such proxy. Any such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders' meeting. A company may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer. Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of votes cast. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the general meeting, the agenda of the general meeting, the proposal submitted to the decision of the general meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box. Voting forms, which show neither a vote in favour nor against the resolution, or an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to. Art. 25. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of April and shall terminate on the thirty-first day of March of the following year. Art. 26. Distributions. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare dividends from time to time. Interim dividends may be distributed upon decision of the Board.
84686 No distribution of dividends may be made if, as a result thereof, the capital of the Company became less than the minimum prescribed by law. A dividend declared but not paid on a share during five (5) years cannot thereafter be claimed by the holder of that share, shall be forfeited by the holder of that share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares. Title V. Dissolution, Liquidation Art. 27. Dissolution. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds may be distributed in kind to the holders of shares. Art. 28. Liquidation and Amalgamation. If the net assets of any Sub-Fund or Class fall below or do not reach an amount determined by the Board at its discretion to be the minimum level for such Sub-Fund or Class to be operated in an economically efficient manner or if a change in the economic, monetary or political situation relating to the Sub-Fund or Class concerned justifies it or in order to proceed to an economic rationalisation, the Board has the discretionary power to liquidate that Sub-Fund or Class by compulsory redemption of shares of the Sub-Fund or Class at the Net Asset Value per share (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) determined as at the Valuation Day at which such a decision shall become effective. The decision of the liquidation will be published by the Company prior to the effective date of the liquidation and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the Board decides otherwise in the interests of, or in order to ensure equal treatment of, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or Class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of redemption or conversion charges (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses). Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a general meeting of Shareholders of any Sub-Fund or Class may, upon proposal from the Board and with its approval, redeem all the Shares of that Sub- Fund or Class and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their Shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) determined as at the Valuation Day at which such a decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such a general meeting of Shareholders at which resolutions shall be adopted by simple majority of the votes cast. Assets which could not be distributed to the relevant shareholders upon the close of the liquidation of a Sub-Fund or Class will be deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant shareholders. Amounts not claimed will be forfeited in accordance with Luxembourg law. Upon the circumstances provided for above, the Board may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment ("UCI"), or to another sub-fund within that other UCI (the "new Sub-Fund") and to re-designate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders),. Such a decision will be notified to the shareholders concerned (together with information in relation to the new Sub-Fund), one month before the date on which the amalgamation becomes effective in order to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period. After that period, the decision commits the entirety of shareholders who have not used this possibility, provided however that, if the amalgamation is to be implemented with a Luxembourg UCI of the contractual type ("fonds commun de placement") or a foreign based undertaking for collective investment, the decision shall be binding only on the shareholders who are in favour of the amalgamation. Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a contribution of the assets and liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund of the Company or to another UCI or to another sub-fund within that UCI may be decided upon by a general meeting of the shareholders, upon proposal from the Board and with its approval, of the contributing Sub-Fund for which there shall be no quorum requirements and which shall decide upon such an amalgamation by resolution adopted by simple majority of the votes cast, except when the amalgamation is to be implemented with a Luxembourg UCI of the contractual type ("fonds commun de placement") or a foreign-based UCI, in which case resolutions shall be binding only on the shareholders of the contributing Sub-Fund who have voted in favour of the amalgamation. Title VI. Final provisions Art. 29. Custodian. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall satisfy the requirements of the Luxembourg laws and the Law (the "Custodian"). In case of withdrawal of the Custodian, whether voluntarily or not, the Custodian will remain in function until the appointment which must happen within two months of another eligible credit institution. Should the appointment of a new custodian not be effective after a period of two (2) months after the effective date of the termination of the custodian agreement, the Custodian shall take all actions necessary for the preservation of the interests of the investors of the Company.
Art. 30. Amendment of the Articles. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg. By derogation to the foregoing, any change to a provision affecting the rights of Class S shareholders will be subject to the consent of all Class S shareholders. For the avoidance of doubt, the consent of Class S shareholders will be required to amend Article 5, paragraphs 9 to 10 and Article 14, paragraphs 3 to 7 hereof. Art. 31. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto (the "1915 Law") and the Law. Transitional dispositions 1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 March 2013. 2) The first annual general meeting shall be held in 2013. Subscription and Payment The subscriber has subscribed for forty-two (42) shares and has paid in cash forty-two thousand USD (USD 42,000). Proof of this payment has been given to the undersigned notary. Expenses The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2.500.-). Statements The notary drawing up this deed declares that the conditions set forth in Article 26, 26-3 and 26-5 of the law of 1915 Law, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Extraordinary general meeting The appearing person has forthwith taken immediately the following resolutions: First resolution The registered office of the Company is set at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; Second resolution The following persons are appointed directors for a period ending at the first annual general meeting which will be held in 2013: - Roland Dominicé, professionally residing at 75, rue de Lyon, Geneva, Switzerland - Vincent Dufresne, professionally residing at 75, rue de Lyon, Geneva, Switzerland - Arnaud Gillin, professionally residing at 5, rue Jean Bertels, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Third resolution KPGM Luxembourg, having its registered office at 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been appointed as auditor of the Company for a period ending at the first annual general meeting. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed is worded in English. Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, this original deed. Signé: C. WILMET et J. BADEN. Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juin 2012. LAC / 2012 / 30264. Reçu soixante quinze euros 75,- - POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande. Luxembourg, le 4 juillet 2012. Référence de publication: 2012080805/798. 84687 (120113605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012. Le Receveur (signé): THILL.
84688 Atelier d'architecture Beng, Société Anonyme, (anc. L'Atelier d'architecture Engel, Bidaine, Goedert, Noury). Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 75, rue Emile Mayrisch. R.C.S. Luxembourg B 93.259. L'an deux mil trois, le dix-sept avril. Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. ONT COMPARU: 1) Monsieur Nico ENGEL, architecte, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 20, rue Bourgrund. 2) Monsieur Marco BIDAINE, architecte, demeurant à L-4482 Belvaux, 38 rue Michel Rodange. 3) Monsieur Albert GOEDERT, architecte, demeurant à L-8522 Beckerich, 10 Juck. 4) Monsieur Yves NOURY, architecte, demeurant à F-57100 Thionville, 12 rue d'angleterre. Lesquels comparants sub. 1) à 4) ont déclaré être les seuls associés de la société civile L'ATELIER D'ARCHITECTURE ENGEL, BIDAINE, GOEDERT, NOURY, SOCIÉTÉ CIVILE avec siège social à L-4004 Esch-sur-Alzette, 5 Domaine Schlassgoart, constituée suivant acte sous seing-privé, en date du 7 mars 1991, publié au Mémorial C de 1991 page 16091. Ceci exposé, lesdits comparants réunis en assemblée générale ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit: I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit: 1) Conversion du capital souscrit et libéré de QUATRE CENT MILLE ANCIEN LUF (400.000.- ANCIEN LUF), au cours de change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro. 2) Acceptation de la démission des gérants actuellement en place avec décharge à leur accorder pour l'accomplissement de leur mandat. 3) Transformation de la société en une société anonyme commerciale avec effet au 31 mars 2003. 4) Augmentation du capital social à concurrence de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE ZERO QUATRE- VINGT-QUATRE VIRGULE VINGT-SIX EURO (490.084,26 EURO) pour le porter de son montant actuel de NEUF MILLE NEUF CENT QUINZE VIRGULE SOIXANTE-QUATORZE EURO (9.915,74EURO) à CINQ CENT MILLE EURO (500.000.- EURO) représenté par CINQ MILLE (5.000) actions de valeur nominale CENT EURO (100.- EURO), et à libérer ladite augmentation de capital intégralement par incorporation d'une créance d'un même montant de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE ZERO QUATRE-VINGT-QUATRE VIRGULE VINGT-SIX EURO (490,084,26 EU- RO), existant contre la société. 5) Changement de la dénomination sociale de la société en "ATELIER D'ARCHITECTURE BENG". 6) Adoption de nouveaux statuts pour réaliser les précédentes résolutions. 7) Nomination d'un conseil d'administration et d'un commissaire aux comptes. 8) Fixation du siège social. II.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes: Première résolution L'assemblée générale décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de QUATRE CENT MILLE ANCIEN LUF (400.000.- ANCIEN LUF) en Euro, au cours de change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro au 1 er janvier 1999, savoir 40,3399, de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion à NEUF MILLE NEUF CENT QUINZE VIRGULE SOIXANTE-QUATORZE EURO (9.915,74.- EURO) représenté par QUATRE CENT (400) parts d'intérêts d'une valeur nominale de VINGT-QUATRE VIRGULE SOIXAN- TE-DIX-NEUF EURO (24,79 ). Deuxième résolution L'assemblée décide d'accepter la démission des gérants actuellement en place et leur accorde décharge pour l'accomplissement de leur mandat. Troisième résolution L'assemblée décide de transformer la société en une société anonyme commerciale avec effet au 31 mars 2003. Quatrième résolution L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE ZERO QUATRE-VINGT-QUATRE VIRGULE VINGT-SIX EURO (490.084,26.-EURO) pour le porter de son montant actuel de NEUF MILLE NEUF CENT QUINZE VIRGULE SOIXANTE-QUATORZE EURO (9.915,74.- EURO) à CINQ CENT MILLE EURO (500.000.- EURO) représenté par CINQ MILLE (5.000) actions de valeur nominale CENT EURO
(100.- EURO), et à libérer ladite augmentation de capital intégralement par incorporation d'une créance d'un même montant de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE ZERO QUATRE-VINGT-QUATRE VIRGULE VINGT-SIX EURO (490.084,26.- EURO) existant contre la société. Souscription Les associés actuels ont déclaré souscrire les actions nouvelles de la société au prorata de leur participation actuelle dans la société et de les libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible jusqu'à concurrence d'un montant de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE ZERO QUATRE-VINGT-QUATRE VIR- GULE VINGT-SIX EURO (490.084,26 EURO) à prélever du compte de créances existant à charge de la société, et au profit des associés actuels, prénommés. L'ensemble du patrimoine appartenant à la société civile L'ATELIER D'ARCHITECTURE ENGEL, BEDAINE, GOE- DERT, NOURY, SOCIÉTÉ CIVILE au moment de la transformation ainsi que ladite créance, élément du passif, a fait l'objet d'un rapport établi par les réviseurs d'entreprises Carlo REDING et Tom PFEIFFER à Luxembourg, en date du 16 avril 2003, lequel conclut comme suit: "Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, pour la transformation de la société civile "L'Atelier d'architecture ENGEL, BIDAINE, GOEDERT, NOURY" en société anonyme et l'augmentation de capital consécutive nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspondent au moins aux 5000 actions de valeur nominale 100 chacune à émettre en contrepartie des apports en nature." L'assemblée accepte le prédit rapport dont un exemplaire dûment paraphé "ne varietur" par l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes, pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement. Les actions sont réparties de la manière suivante: - Monsieur Nico ENGEL, prénommé, 1250 actions. - Monsieur Marco BIDAINE, prénommé, 1250 actions. - Monsieur Albert GOEDERT, prénommé, 1250 actions. - Monsieur Yves NOURY, prénommé, 1250 actions. TOTAL: CINQ MILLE (5.000) actions. Cinquième résolution L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en "ATELIER D'ARCHITECTURE BENG". Sixième résolution L'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les précédentes résolutions. L'assemblée des associés décide de transformer la société L'ATELIER D'ARCHITECTURE ENGEL, BIDAINE, GOE- DERT, NOURY, SOCIÉTÉ CIVILE en société anonyme avec effet au 31 mars 2003 en continuation de la société, sous une autre forme, sans qu'il y ait création d'une société nouvelle et ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux, par la transformation de la prédite société L'ATELIER D'ARCHITECTURE ENGEL, BIDAINE, GOEDERT, NOURY, SOCIETE CIVILE. Les associés, tous présents, décident à l'unanimité, des voix de transformer la société L'ATELIER D'ARCHITECTURE ENGEL, BIDAINE, GOEDERT, NOURY, SOCIÉTÉ CIVILE en société anonyme avec effet au 31 mars 2003, conformément à l'article trois de la loi sur les sociétés commerciales, étant entendu que cette transformation ne doit pas être accompagnée d'un changement des bases essentielles du pacte social, d'une prolongation de la durée de la société, du maintien du capital social, de la fixation du siège social. Il y aura attribution des actions de la société anonyme aux associés en raison d'une action de la société anonyme pour chaque CENT EURO (100.- EURO) de capital de la société civile et chaque CENT EURO (100.- EURO) d'apports à la société anonyme issue de la transformation, la nomination du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour être en comformité, avec la loi sur les sociétés commerciales et la refonte des statuts. Les nouveaux statuts auront donc dorénavant la teneur suivante: "Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1 er. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ATELIER D'ARCHITECTURE BENG. Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Art. 3. La durée de la société est illimitée. 84689
84690 Art. 4. La société a pour objet l'étude, la planification et la réalisation de toutes missions d'architectures et d'urbanisme, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut faire toutes les opérations mobilières, immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci. Art. 5. Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE EURO (500.000.- euro) représenté par CINQ MILLE (5.000) actions d'une valeur nominale de CENT EURO (100.- euro) chacune. Les actions sont nominatives. Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi. Titre II. - Administration, Surveillance Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance d'une place d'administrateur, nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés, ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Art. 8. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si tous les membres sont présents ou si la majorité de ses membres est présente ou représentée et que tous ses membres ont été valablement convoqués par lettre recommandée au moins quatre (4) semaines à l'avance, comportant l'ordre du jour. Le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit ou télécopie est admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication électronique. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Art. 10. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques. Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. Année sociale - Assemblée Générale Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix. Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
84691 Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 09.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts." Septième résolution 1. L'assemblée décide de nommer quatre administrateurs: Sont appelés aux fonctions d'administrateur: - Monsieur Nico ENGEL, architecte, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 20 rue Bourgrund. - Monsieur Marco BIDATME, architecte, demeurant à L-4482 Belvaux, 38 rue Michel Rodange. - Monsieur Albert GOEDERT, architecte, demeurant à L-8522 Beckerich, 10 Juck. - Monsieur Yves NOURY, architecte, demeurant à F-57100 Thionville, 12 rue d'angleterre. 2. L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes: Madame Théa ENGEL, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette. 3. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008. Huitième résolution L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette, 75, rue Emile Mayrisch. Coût Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à SIX MILLE QUATRE CENT EUROS (6.400.- EUR). Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée. Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire Signé: Engel, Bidaine, Goedert, Noury, Biel. Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 avril 2003 Vol.: 888, fol.: 9, case: 6. Reçu: quatre mille neuf cents euros quatrevingts-quatre cents$490084,26 à 1% - 4900,84. Le Receveur (signé): M. RIES. POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2003. Référence de publication: 2012083402/193. (030022027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003. A. BIEL. Compo AcquiCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Colada AcquiCo S.à r.l.). Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen. R.C.S. Luxembourg B 159.796. In the year two thousand and twelve, on fifth day of June, before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, there appeared: Compo Co-Invest S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161245 (the "Shareholder"), hereby represented by Mr Marc Frantz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on June 4, 2012, The said proxy shall be annexed to the present deed. The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Colada AcquiCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro and three cent (EUR 12,500.03), with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed
84692 dated 21 March 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1412 of 29 June 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.796 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have last been amended pursuant to a notarial deed dated 18 January 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 834 of 29 March 2012. The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda: Agenda 1. To change the name of the Company to "Compo AcquiCo S.à r.l.". 2. To amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolutions. 3. Miscellaneous. requested the undersigned notary to record the following resolutions: First resolution The Shareholder resolved to change the name of the Company to "Compo AcquiCo S.à r.l.". Second resolution In view of the above, the Shareholder resolved to amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolution, such paragraph being from now on read as follows: "The Company will exist under the name of "Compo AcquiCo S.à r.l."." Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of inconsistencies between the English and the French text, the English text will prevail. The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his or her surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the notary this original deed. L'an deux mille douze, le cinq juin, Suit la traduction française du texte qui précède: par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a comparu: Compo Co-Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161245 (l' «Associé»), représentée aux fins des présentes par M. Marc Frantz, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 4 juin 2012. La prédite procuration restera annexée aux présentes. L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'associé est le seul et unique associé de Colada AcquiCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros et trois centimes (EUR 12.500,03), dont le siège social est au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 21 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1412 du 29 juin 2011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 159.796 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 18 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 834 du 29 mars 2012. L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant: Ordre du jour 1. Modification de la dénomination sociale de la Société en "Compo AcquiCo S.à r.l.". 2. Modification le troisième alinéa de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter la résolution proposée cidessus. 3. Divers. Ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
84693 Première résolution L'Associé a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société en «Compo AcquiCo S.à r.l.». Deuxième résolution En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l'associé a décidé de modifier le troisième alinéa de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter la précédente résolution, cet alinéa ayant dorénavant la teneur suivante: «La Société existe sous la dénomination sociale «Compo AcquiCo S.à r.l.»» Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande au même comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra. Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte. Signé: M. Frantz, M. Loesch. Enregistré à Remich, le 12 juin 2012, REM/2012/629. Reçu soixante-quinze euros. 75,00. Pour expédition conforme. Mondorf-les-Bains, le 20 juin 2012. Référence de publication: 2012071543/89. (120102411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Sundsval Invest S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey. R.C.S. Luxembourg B 137.427. Le Receveur (signé): P. MOLLING. Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale tenue le 19 juin 2012 Le nouveau siège social est fixé au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg. L'assemblée générale prend acte de la démission de Messieurs Angelo ZITO, Francesco ZITO et Pascal ROBINET de leurs fonctions d'administrateurs. L'assemblée générale prend acte de la démission de la société FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes. Constatant que la société est détenue par un associé unique, l'assemblée générale nomme Monsieur Jean-Luc JOUR- DAN, demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg aux fonctions d'administrateur unique pour un mandat échéant à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2018. L'assemblée générale nomme la société GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l. avec siège social au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2018. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Référence de publication: 2012071909/20. (120102278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Bayerische Entwicklung S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial. Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 76.529. Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 29 mars 2012 Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A.; Monsieur Hugues DUMONT, né le 3 mars 1959 à Ixelles (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A. Pour la société BAYERISCHE ENTWICKLUNG S.A.,SPF Référence de publication: 2012071517/14. (120102420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.
84694 Discovery S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial. Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 28.991. Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 29 mars 2012 Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A.; Monsieur Hugues DUMONT, né le 3 mars 1959 à Ixelles (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A. Pour la société DISCOVERY S.A. Société de gestion de patrimoine, «SPF» Référence de publication: 2012071592/16. (120102421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Finantel S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial. Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 49.316. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2012 Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance. Monsieur Norbert SCHMITZ adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans. Pour la société FINANTEL S.A., SPF Référence de publication: 2012071633/16. (120102464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Lillington International S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 72.716. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2011. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance. Messieurs Norbert SCHMITZ adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et Giancarlo CO- DONI adresse professionnelle au 1, Riva Albertolli, CH-6901 Lugano, et la société S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans. Pour la société LILLINGTON INTERNATIONAL S.A. Référence de publication: 2012071752/16. (120102465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Setas International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial. Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'esch. R.C.S. Luxembourg B 23.519. Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 21 mai 2012 - Il est pris acte de la démission de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI de son mandat d'administrateur avec effet à ce jour.
- Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, né le 10 août 1977 à Carpentras (France), employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, démissionnaire, avec effet à ce jour, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée Générale Statutaire de l'an 2015. - Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, né le 10 août 1977 à Carpentras (France), employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'esch, L-2086 Luxembourg en tant que Président du Conseil d'administration jusqu'au terme de son mandant à savoir l'assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2015. Luxembourg, le 21 mai 2012. SETAS INTERNATIONAL S.A. CH. FRANCOIS / P. MESTAGH Administrateur / Adminsitrateur 84695 Référence de publication: 2012071890/22. (120102325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. FHL, Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, Association sans but lucratif. Siège social: L-8070 Bertrange, 5, rue des Mérovingiens. R.C.S. Luxembourg F 1.544. Dénomination, Siège et Objet Art. 1 er. L'association, dénommée «Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois», en abrégé «FHL», est une association sans but lucratif regroupant les établissements hospitaliers luxembourgeois. Peuvent être associés des institutions ou structures oeuvrant dans le secteur hospitalier. Sa durée est illimitée. Son siège social est établi à Bertrange. Il peut être transféré en toute autre localité au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale. Art. 2. L'association a pour objet le groupement des établissements hospitaliers luxembourgeois, la défense des intérêts professionnels de ses membres et la réalisation sous toutes ses formes du progrès hospitalier pour concourir notamment au bien-être du patient. Elle le fera dans un esprit de parfaite indépendance politique et confessionnelle et pourra se doter à cette fin des structures nécessaires pour remplir ses missions. Par établissement hospitalier, dans le sens des présents statuts, il faut entendre un établissement répondant aux conditions cumulatives suivantes: - être inscrit au plan hospitalier national - être régi par les conventions entre la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (FHL) et la Caisse Nationale de Santé (CNS) ou autres organismes de Sécurité Sociale, ainsi que par la Convention Collective de Travail concernant son personnel, - comporter un ou plusieurs services d'examens et de traitement dans lesquels les personnes sont admises en vue d'y subir un examen ou un traitement médical, chirurgical ou obstétrical. Est visée également d'une façon générale toute institution ou structure publique ou privée qui n'est pas expressément désignée dans les présents statuts à condition cependant de poursuivre une activité dans le domaine médical, de la santé ou des soins en lien avec le secteur hospitalier. L'association a notamment, dans le cadre de son objet défini ci-dessus, comme mission: 1. d'élaborer la stratégie commune à moyen et à long terme pour le secteur hospitalier, de constituer à cet effet une plateforme d'échange et de concertation étroite entre ses membres ayant pour objectif d'arriver à un accord sur les dossiers majeurs du secteur, 2. d'assurer, de piloter et de faciliter la mise en œuvre concrète des décisions prises en son sein pour mettre en pratique la stratégie commune retenue et intervenir en ce sens auprès des acteurs publics et privés, 3. de mener pour le compte des membres les négociations en vue de la passation avec les institutions de la sécurité sociale des conventions prévues par les lois et de servir d'intermédiaire pour les questions de principe se posant dans les relations entre ses membres d'une part et les autorités publiques et les institutions de sécurité sociale d'autre part, 4. de représenter ses membres vis-à-vis de tiers pour les prises de position et actions décidées en commun et de mener pour le compte de ses membres les négociations en vue de la passation de conventions de tous genres avec des tiers, 5. d'œuvrer ensemble avec ses membres pour favoriser le progrès technique et scientifique ainsi que l'innovation, 6. d'organiser et de développer les rapports avec les associations hospitalières étrangères et d'adhérer aux organismes internationaux visant des buts analogues, 7. d'une manière générale, de veiller et répondre aux intérêts communs et aux besoins particuliers de tous ses membres en tenant compte des dispositions légales et réglementaires notamment en matière de santé publique.
84696 Membres Art. 3. Peuvent devenir membres les établissements et structures tels que définis à l'article 2 des présents statuts, représentés par leurs organismes gestionnaires, personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, et qui acceptent d'adhérer à et d'appliquer la CCT du secteur hospitalier. Les demandes d'admission sont adressées au Conseil d'administration qui les soumet au vote de la prochaine Assemblée générale. Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à cinq. Art. 4. Chaque membre paie une cotisation de base qui est fixée annuellement par l'assemblée générale. Cette cotisation ne dépassera pas la somme de 1.500.- EUR (mille cinq cents Euros). Les membres paient en outre des participations financières annuelles en fonction de critères arrêtés selon les divers volets budgétaires par l'assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration. Ces participations financières annuelles représentent les diverses contributions des membres pour les prestations leur offertes par l'association. Les critères tiendront prioritairement compte du budget opposable pour les établissements budgétisés CNS et du bilan annuel pour les autres membres. Les cotisations et participations financières sont dues pour l'année entière, quelle que soit la date de l'admission. Art. 5. La qualité de membre se perd par: 1. la démission volontaire 2. l'exclusion pour des motifs graves, 3. la non-conformité aux dispositions de l'article 2 des présents statuts. Les droits sociaux des membres qui n'ont pas payé leur cotisation ou leurs participations financières au jour de l'assemblée générale sont suspendus jusqu'au règlement de l'arriéré. Est réputé démissionnaire le membre qui, n'ayant pas payé sa cotisation ou ses participations financières à la fin de l'exercice, reste en défaut de s'exécuter dans les trois mois suivant une mise en demeure notifiée par lettre recommandée. La démission volontaire est à adresser par écrit recommandé au Président du Conseil d'administration. L'exclusion pour des motifs graves est prononcée suivant scrutin secret par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. Les membres démissionnaires ou exclus ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations ou participations financières échues; ils n'ont aucun droit aux biens de l'association. Pour la période avant la démission ou l'exclusion, les cotisations et les participations financières restent dues. Assemblée générale Art. 6. L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année et au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social précédent. Les membres sont convoqués par lettre circulaire recommandée par le Conseil d'administration avec communication de l'ordre du jour au moins trois semaines calendaires avant la date de la réunion. Art. 7. Le Conseil d'administration peut, pour autant que de besoin, convoquer des Assemblées générales extraordinaires dans les délais prévus à l'article 6. Art. 8. Une Assemblée générale extraordinaire doit en outre être convoquée dans les trois semaines calendaires de la demande afférente lorsqu'un cinquième des membres ou lorsqu'un nombre de membres, réunissant au moins un cinquième des voix, l'exige par écrit en indiquant l'ordre du jour. En cas d'urgence, ces délais peuvent être plus courts. Les décisions prises devront alors être avalisées par l'assemblée générale suivante convoquée suivant les modalités habituelles. Le nombre de voix dont dispose chaque membre à l'assemblée générale est défini à l'article 11 ci-dessous. Art. 9. L'Assemblée générale délibère sur les problèmes dont compétence lui est reconnue par la loi sur les associations sans but lucratif et/ou par les présents statuts. Art. 10. Toute proposition signée par un vingtième des membres ou par un nombre de membres réunissant au moins le vingtième des voix doit être portée à l'ordre du jour. L'Assemblée générale qui réunit effectivement ou par représentation au moins les trois quarts des membres peut décider à sa majorité d'admettre toute proposition ou tout autre point éventuel à l'ordre du jour. Art. 11. Dans les Assemblées générales, chaque membre dispose d'un nombre de voix proportionnel au montant total des cotisations et participations financières payées pour l'année précédente. Le droit de vote devient effectif à dater de la réunion de l'assemblée générale qui suit l'assemblée générale qui a approuvé l'adhésion du nouveau membre. Art. 12. Chaque membre peut donner procuration écrite à un autre membre de voter pour lui et en son nom. La procuration ne vaut que pour une Assemblée générale.
Aucun membre ne peut représenter plus d'un membre. 84697 Art. 13. L'Assemblée générale délibère et décide valablement seulement si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il sera convoqué, dans les délais prévus par l'article 6 des présents statuts, une seconde Assemblée générale qui décide valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, sauf les dérogations prévues par la loi. Le vote se fait à haute voix par le représentant délégué à cette fin par chacun des établissements membres, sauf si des personnes physiques sont directement concernées à titre individuel. Dans ces cas, il est procédé par scrutin secret, dont la procédure est fixée par le Conseil d'administration. Lors des votes, un partage des voix dont dispose chaque établissement membre n'est pas possible. Art. 14. Les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou à son défaut par le Vice-président respectivement par l'administrateur le plus ancien en rang et, à parité entre plusieurs, l'administrateur le plus âgé. Art. 15. Les délibérations et décisions de l'assemblée générale sont actées dans un registre ad hoc que tous les membres peuvent consulter au siège social et qui est signé par le Secrétaire Général ainsi que par le Président du Conseil d'administration ou à son défaut par le Vice-président respectivement par l'administrateur le plus ancien en rang et, à parité entre plusieurs, l'administrateur le plus âgé. Conseil d'administration Art. 16. L'association est administrée par un Conseil d'administration. Les membres de l'association y sont représentés soit de manière directe soit de manière indirecte. Le Conseil d'administration est composé comme suit: - Chaque centre hospitalier régional a droit à 3 membres. - Chaque hôpital général a droit à 2 membres. - Chaque établissement hospitalier spécialisé, budgétisé et constitué en personne morale indépendante, a droit à un membre. L'association est présidée par un Président, et en son absence par un Vice-président, librement choisis par l'assemblée générale parmi les candidats proposés par ses membres. Pour autant que le Président ne soit pas issu d'un établissement membre, il a la qualité d'administrateur s'ajoutant au nombre d'administrateurs résultant de l'alinéa précédent. L'Assemblée générale désigne pour la durée de quatre années les commissaires aux comptes. Chaque administrateur dispose d'une voix au Conseil d'administration. Les candidats pour les postes d'administrateurs sont soumis au vote de l'assemblée générale. Cette répartition peut être révisée par l'assemblée générale en cas d'admission de nouveaux membres ou en cas de démission de membres. Art. 17. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Le mandat des administrateurs est renouvelable. Art. 18. Le Conseil d'administration peut choisir dans son sein un Trésorier. La durée des mandats du Président, du Vice-président et du Trésorier est de quatre années, renouvelable. En l'absence du Président et du Vice-président, l'administrateur effectif le plus ancien en rang et, à parité entre plusieurs, l'administrateur effectif le plus âgé est investi des fonctions de la présidence. Les fonctions de Président, Vice-président, Trésorier et d'administrateur peuvent donner droit à des indemnités et/ ou des jetons de présence. Si le Président de l'association ne peut plus exercer son mandat ou s'il y renonce, le Vice-président exercera provisoirement le mandat de Président jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui statuera définitivement sur son remplacement. Art. 19. Les droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont ceux prévus par la loi. Les pouvoirs non réservés à l'assemblée générale appartiennent au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Les modalités d'application sont détaillées au règlement général prévu à l'article 26 des présents statuts. Le Conseil d'administration clôture les écritures de l'exercice révolu et dresse le bilan; il établit le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir. Art. 20. Le Conseil d'administration délègue certains de ses pouvoirs à un Bureau. Le Bureau a notamment comme mission de préparer les réunions du Conseil d'administration et de veiller au suivi des décisions prises lors des réunions du Conseil d'administration. En cas d'urgence et en l'absence de réunion du Conseil d'administration, le Bureau pourra prendre toutes décisions qui s'imposeront dans l'intérêt de l'association et de ses membres. Le Bureau est composé comme suit: - Le Président du Conseil d'administration.
84698 - Les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et hôpital général tels que repris dans le plan hospitalier - Un directeur général d'un établissement hospitalier spécialisé tel que repris dans le plan hospitalier et représentant les établissements hospitaliers spécialisés. Les membres du Bureau doivent avoir la qualité d'administrateur effectif. Participent également aux réunions du Bureau à titre d'invités: - Les coordinateurs des plateformes (médicale, soins, administrative et financière), - Le Secrétaire Général. L e règlement général détermine le fonctionnement ainsi que les domaines d'actions du Bureau. Art. 21. Les directions médicales, soignantes et administratives-financières des établissements hospitaliers constituent pour leurs domaines respectifs des plateformes de concertation sur des sujets d'intérêt commun. Les trois plateformes PF-DM (plateforme des directeurs médicaux), PF-DS (plateforme des directeurs soins) et PF- DAF (plateforme des directeurs administratifs et financiers) préparent, organisent et coordonnent les travaux pour le Bureau et pour le Conseil d'administration dans leurs domaines d'activité respectifs et en assurent le suivi. Chaque plateforme désignera un coordinateur choisi parmi les membres effectifs du Conseil d'administration. Le règlement général détermine le fonctionnement ainsi que les domaines d'actions des trois plateformes. Art. 22. Le Conseil d'administration délègue la gestion journalière de l'association à un secrétariat général sous la direction et sous la responsabilité d'un Secrétaire Général. Le Secrétariat Général assiste les organes de l'association dans leurs travaux et en assure le volet opérationnel. Pour le cas où le Secrétaire Général ne serait plus à même d'exercer ses fonctions, le Conseil d'administration peut charger une ou plusieurs personnes de procéder, conformément à ses directives, à l'expédition des affaires journalières. Art. 23. L'association est engagée à l'égard des tiers par les signatures conjointes du Président ou Vice-président du Conseil d'administration d'une part et du Secrétaire Général ou d'un autre administrateur d'autre part, sans préjudice d'autres modalités de signature à prévoir dans le règlement général. Art. 24. Le Conseil d'administration peut recourir à des conseillers techniques et/ou à des commissions d'études, qui pourront assister sur convocation et à titre consultatif aux réunions et assemblées. Le Conseil d'administration fixera le cas échéant leurs rémunérations. Art. 25. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président ou, à défaut de celui-ci, du Vice-président, aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige et en principe tous les deux mois. Il ne pourra valablement statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat écrit donné par un administrateur à un de ses collègues de le représenter aux délibérations dudit Conseil n'est valable que pour une seule séance. Un même membre du Conseil ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. Chaque personne membre du Conseil d'administration peut également se faire représenter par un membre suppléant préalablement nommé par l'assemblée générale. Cette règle ne s'applique cependant pas pour le poste de Président. Chaque personne membre du Conseil d'administration ne peut être représentée qu'une seule fois, soit par son suppléant, soit par procuration. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés; en cas de parité de voix, celle du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Le vote se fait par main levée, sauf si des personnes physiques sont directement concernées à titre individuel. Dans ces cas, le scrutin secret peut être demandé. Les résolutions du Conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le secrétariat général et communiqués à tous les administrateurs. Règlement général - Le fonctionnement ainsi que les domaines d'action du Bureau, des trois plateformes et du Secrétariat Général; - les modalités de la délégation de compétence et de la délégation de signature; l'organigramme du secrétariat général; - les modalités pour l'établissement d'un règlement interne concernant le secrétariat général; - la structuration, le fonctionnement et l'organigramme des organes collégiaux internes voire externes; - les modalités de paiement des indemnités, frais de route, jetons de présence et frais de représentation; - les modalités de diffusion des informations; - le statut et la carrière des salariés de l'association; - les modalités d'engagement et de licenciement du personnel de l'association; - les profils de poste pour chaque fonction exercée dans l'association. Exercice social, Budget et Comptes Art. 27. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Les années paires, le budget des recettes et des dépenses pour les deux exercices à venir est dressé pour l'assemblée générale. Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés avant le trente et un mars de l'année suivante. Le bilan et le budget sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. L'Assemblée générale peut le cas échéant arrêter, les années impaires, des budgets rectifiés pour le deuxième exercice. Le budget approuvé peut être exécuté au-delà du 31 décembre mais avant l'assemblée générale de l'année suivante à condition d'être provisionné dans le bilan. Dissolution Art. 28. En cas de dissolution de l'association, pour quelque cause que ce soit, il sera donné à l'actif net de l'association, tel qu'il résulte de la liquidation effectuée conformément à la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée, une affectation autant que possible en rapport avec l'objet en vue duquel l'association a été créée. Cette affectation sera déterminée par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, ou à défaut par les personnes chargées de la liquidation de l'association. Bertrange, le 8 juin 2012. Marc HASTERT Secrétaire Général 84699 Référence de publication: 2012072616/220. (120102259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Marita Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial. Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri. R.C.S. Luxembourg B 47.427. L'an deux mille douze, le onze juin. Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg. S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "MARITA Spf S.A.", enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.427, ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 19 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 324 du 6 septembre 1994. Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1039 du 19 mai 2009. La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine ORTWERTH, employée privée, domiciliée professionnellement au 3A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Sylvie DUPONT, employée privée, domiciliée professionnellement à la même adresse. Madame le Président expose ensuite: I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept mille cinq cents (7.500) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000.- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procèsverbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit: 1. Renonciation aux modalités légales relative aux convocations de l'assemblée. 2. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société. 3. Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs. L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes: Première résolution L'Assemblée générale renonce expressément aux convocations préalables à la présente assemblée, confirmant être suffisamment informée de l'ordre du jour, se considère comme valablement convoquée et décide de délibérer et de voter sur les points portés à l'ordre du jour. L'Assemblée générale déclare que les documents produits lors de la présente assemblée lui ont été mis à disposition pendant un délai suffisamment long lui ayant permis d'examiner chaque document.
84700 Deuxième résolution L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation. Troisième résolution L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Etienne GILLET, administrateur de sociétés, né le 19 septembre 1968 à Bastogne (Belgique), professionnellement domicilié au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Frais Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont évalués à neuf cents euros (900.- EUR) et sont à charge de la société. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute. Signé: S. Ortwerth, G. Saddi, S. Dupont et M. Schaeffer. Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juin 2012. LAC/2012/27769. Reçu douze euros (12,- ). Le Receveur (signé): Irène Thill. POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 20 juin 2012. Référence de publication: 2012071773/60. (120102302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. M.F.L. S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier. R.C.S. Luxembourg B 57.727. EXTRAIT Suivant décision du Conseil d'administration tenu en date du 31 mai 2012, le siège social de la société a été transféré du 18, rue de l'eau L-1449 Luxembourg au 38, Boulevard Napoléon 1 er, L-2210 Luxembourg. Pour extrait conforme Référence de publication: 2012071760/11. (120102433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Succursale Gaz Métro International, Succursale d'une société de droit étranger. Loi sur les sociétés par actions J'atteste que la société par actions 9264-5944 Québec inc. Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann. R.C.S. Luxembourg B 169.498. Certificat de constitution a été constituée le 12 juin 2012, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, comme l'indiquent les statuts de constitution ci-joints. Déposé au registre le 12 juin 2012 sous le numéro d'entreprise du Québec 1168328681. Signature Registraire des entreprises STATUTS DE CONSTITUTION Accusé de réception. La demande a été transmise avec succès le 12 juin 2012 à 15 h 34 min 26 s. Le numéro de référence est 020200007633063. Merci d'avoir utilisé nos services en ligne.
Nom de la société par actions. La désignation numérique de la société par actions vous sera transmise à la suite de l'analyse de votre demande. Adresse du siège. Adresse 1717 rue du Havre Montréal (Québec) H2K2X3 Canada Membres du conseil d'administration. Nombre de membres du conseil d'administration 1 à 10 Nom Burelle, Lyne Adresse 24 av. Fenwick Montréal-Ouest (Québec) H4X1P5 Canada Nom Despars, Pierre Adresse 85 rue des Lys La Prairie (Québec) J5R5J9 Canada Capital-Actions, Restrictions et Limites. Capital-actions autorisé Nombre illimité d'actions ordinaires Restrictions sur le transfert des titres ou actions et Autres dispositions. Nom du fichier Annexe 1.pdf Limites imposées aux activités. Aucune limite Fondateurs. Nom de famille et Nom prénom Loi constitutive Adresse Paradis, François 2100-1000 RUE De La Gauchetière O Montréal Québec H3B4W5 Canada Date et heure d'entrée en vigueur des statuts Date d'entrée en vigueur 12 juin 2012 Heure d'entrée en vigueur 0 h 0 min 84701 STATUTS DE CONSTITUTION Ce formulaire s'adresse à toute personne qui désire constituer une société par actions régie par la Loi sur les sociétés par actions. Veuillez lire les renseignements aux pages 3 et 4 avant de remplir ce formulaire. 1. Nom. Inscrivez le nom de la société et sa version dans une autre langue, s'il y a lieu. N'inscrivez rien si vous demandez une désignation numérique au lieu d'un nom. Cochez la case appropriée: - Nous demandons une désignation numérique au lieu d'un nom. - Nous demandons un nom et nous confirmons que nous avons pris des moyens raisonnables pouf nous assurer que le nom choisi est conforme à la loi. 2. Nombre d'administrateurs. Inscrivez le nombre exact d'administrateurs ou leur nombre minimal et maximal. Minimum: 1, Maximum: 10 3. Date d'entrée en vigueur. Inscrivez la date d'entrée en vigueur si elle est postérieure à celle de la réception des statuts. 4. Heure d'entrée en vigueur. Inscrivez l'heure d'entrée en vigueur, le cas échéant. - heures minutes - avant-midi - après-midi 5 Capital-actions autorisé et Limites imposées - Décrivez le capital-actions autorisé et les limites imposées. Sauf indication contraire dans les statuts, la société a un capital-actions illimité et ses actions sont sans valeur nominale. (Voir la section «Description du capital-actions» à la page 3.) Nombre illimité d'actions ordinaires Retournez ce formulaire accompagné des documents exigés et du paiement requis. 6. Restrictions et Autres dispositions. Inscrivez les restrictions sur le transfert des titres ou des actions et les autres dispositions, s'il y a lieu. Voir l'annexe 1 ci-jointe 7. Limites imposées aux activités. Inscrivez les limites imposées aux activités, s'il y a lieu. Aucune 8. Fondateurs. Inscrivez le nom de famille, le prénom et l'adresse du domicile du ou des fondateurs ou le nom et l'adresse du siège de la personne morale agissant à ce titre. Nom de famille et prénom ou nom de (a personne morale agissant à titre de fondateur: Paradis, François
84702 Appartement: 2100 Numéro: 1000 Rue: rue de la Gauchetière Ville, village ou municipalité: Montréal Province: QC Pays: Canada Code postal: H 3 B 4 W 5 Loi constitutive (avec référence exacte) de la personne morale agissant à titre de fondateur Signature Fondateur ou de la personne autorisée par la personne morale Annexe 1 Restrictions sur le transfert de titres (incluant les actions) Aucun titre de la Société, autre que des titres de créance non-convertibles, ne pourra être transféré sans l'approbation du conseil d'administration ou du détenteur ou des détenteurs de plus de 50% des actions donnant droits de vote de la Société, exprimée par résolution du conseil, du détenteur ou des détenteurs. Autres dispositions L'assemblée annuelle des actionnaires de la Société peut être tenue à tout endroit, dans la province de Québec ou ailleurs, tel que les administrateurs peuvent le déterminer. Référence de publication: 2012071877/84. (120102037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Melodium S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 96.793. Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 28 mars 2012. Monsieur Javier ARELLANO, né le 22 septembre 1973 à Cadiz (Espagne), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A., en remplacement de Monsieur Jordi CATALA. Pour la société MELODIUM S.A. Référence de publication: 2012071777/13. (120102463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Merym S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 90.125. Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 06 mars 2012 Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Norbert SCHMITZ, domicilié professionnellement au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Maurice GENOYER, administrateur démissionnaire. Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale. Monsieur Maurice GENOYER démissionne également de son mandat d'administrateur-délégué, et ne sera pas remplacé. Pour la société MERYM SA Référence de publication: 2012071778/17. (120102466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Monitor-IT S.A., Société Anonyme. Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 111.857. Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
84703 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Senningerberg, le 20 juin 2012. Référence de publication: 2012071782/10. (120102184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. PP Group S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel. R.C.S. Luxembourg B 118.752. Extrait des résolutions de l'assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2012 NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS, DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE REVISEUR D'ENTREPRISES L'assemblée a décidé: 1/ De renouveler le mandat d'administrateur des personnes suivantes jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire de 2018: - Monsieur Vincent Bechet, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, - Monsieur Marc Baertz, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, - Monsieur Frank Rosenbaum, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, - Madame Angélique Sabron - Souty, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, - Monsieur Stéphane Terver, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg. 2/ De renouveler le mandat de Monsieur Paul Mathes, résidant 22, rue de Larochette, L-7640 Christnach, en tant que Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire de 2018. 3/ De désigner la société BDO Audit S.A., établie et ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 2 Avenue Charles de Gaulle, comme réviseur d'entreprises de la société. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de 2012. Référence de publication: 2012071834/21. (120102292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. QGOG Constellation S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey. R.C.S. Luxembourg B 163.424. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2012 Dépôt Complémentaire au dépôt numéro L120069721 déposé le 30 avril 2012 L'Assemblée a décidé de consolidé les mandats de tous ces administrateurs: 1. Monsieur Guilherme De Araujo Lins, en tant qu'administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle à 35 Chemin de Le Californie, 1222, Vesenaz, Switzerland; 2. Monsieur Ricardo De Queiroz Galvao, en tant qu'administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle 51 Av. Presidente Antonio Carlos, étage 5 Floor, BR-20020-010 Rio de Janeiro; 3. Monsieur Antonio Augusto De Queiroz Galvao, en tant qu'administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle 51 Av. Presidente Antonio Carlos, étage 5 Floor, BR-20020-010 Rio de Janeiro; 4. Monsieur Onno Bouwmeister, en tant qu'administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; 5. Monsieur Peter van Opstal, en tant qu'administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; Ses mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014. Luxembourg. Pour extrait conforme Pour la société Un mandataire Référence de publication: 2012071844/25. (120102406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.
84704 PP Group S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel. R.C.S. Luxembourg B 118.752. Extrait des résolutions du conseil d'administration du 15 mai 2012 ELECTION DU BUREAU, MANDAT D'ADMINISTRATEUR DELEGUE Le Conseil d'administration a décidé: 1/ De nommer Monsieur Vincent Bechet, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, comme Président du Conseil jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire de 2018. 2/ De reconduire Monsieur Vincent Bechet, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en tant qu'administrateur Délégué de la société, jusqu'à l'assemblée Générale de 2018. Référence de publication: 2012071835/14. (120102292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Bryni Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Novator Credit Luxembourg S.à r.l.). Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal. R.C.S. Luxembourg B 115.567. In the year two thousand and twelve. On the seventh day of May. Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg. There appeared: The company Novator Credit Opportunities Master Fund, having its registered office in Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Mr Jan ROTTIERS, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal. Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities. This appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act: That the appearing party is the sole actual partner of Novator Credit Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company, with registered office in L-2449 Luxembourg, 25c, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg number B 115567, incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on the 9 th of March 2006, published in the Mémorial C number 1227 of the 26 th of June 2006, and that it has taken the following resolution: Resolution The sole shareholder decides to change the name of the company into Bryni Luxembourg S.à r.l. and subsequently amends article four of the articles of incorporation as follows: " Art. 4. Name. The Company will have the name of Bryni Luxembourg S.à r.l." Costs The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at eight hundred Euro. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the proxy-holder person signed together with us, the notary, the present original deed. Suit la version en langue française du texte qui précède: L'an deux mille douze, le sept mai. Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg. A comparu:
La société Novator Credit Opportunities Master Fund, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, ici représentée par Monsieur Jan ROTTIERS, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé. Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit: Que la comparante est la seule associée actuelle de Novator Credit Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25c, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg numéro B 115567, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mars 2006, publié au Mémorial C numéro 1227 du 26 juin 2006, et qu'elle a pris la résolution suivante: Résolution L'associée unique décide de changer la dénomination de la société en Bryni Luxembourg S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts comme suit: " Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination Bryni Luxembourg S.à r.l." Frais Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cents euros. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte. Signé: Jan ROTTIERS, Jean SECKLER. Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2012. Relation GRE/2012/1621. Reçu soixante-quinze euros (75,- ). Le Receveur (signé): G. SCHLINK. Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Junglinster, le 20 juin 2012. 84705 Référence de publication: 2012071801/71. (120102165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Nsearch S.A., Société Anonyme. Siège social: L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle. R.C.S. Luxembourg B 67.786. Im Jahre zwei tausend und zwölf, den zweiundzwanzigsten Mai. Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg); Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "NSearch S.A.", mit Sitz zu L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion D unter der Nummer 67.786. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den damals in Mersch residierenden Notar Edmond SCHROEDER, am 8. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 171 vom 16. März 1999. Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Régis LUX, Angestellter, berufsansässig in Luxemburg, 196, rue de Beggen. Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin und die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Isabell FELTEN, Angestellte, berufsansässig in Luxemburg, 196, rue de Deggen. Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest. I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist. II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung "ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.
84706 III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten. IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte: Tagesordnung 1.- Beschluss den Gesellschaftssitz von L-1279 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg, nach L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle, zu verlegen und dementsprechend Artikel 1 der Satzung abzuändern 2.- Verschiedenes. Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: Erster Beschluss Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft nach L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle zu verlegen. Zweiter Beschluss Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor getätigte Abänderung beschließt die Generalversammlung den 2. Satz von Artikel 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben: " Art. 1. (2. Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher." Kosten Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 850,- EUR veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen. WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben. Gezeichnet: Régis LUX, Isabell FELTEN, Jean SECKLER. Enregistré à Grevenmacher, le 25 mai 2012. Relation GRE/2012/1851. Reçu soixante-quinze euros (75,- ). Le Receveur (signé): G. SCHLINK. Für gleichlautende Kopie erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Junglinster, den 20. Juni 2012. Référence de publication: 2012071807/52. (120102197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Orcade S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 77.410. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 février 2012 Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance. Messieurs Medhi DAZI, adresse, rue Lafayette, Bât 7, 16000 Alger Centre, Algérie, et Norbert SCHMITZ, adresse au 16, rue Eugène Wolff, L-2736 Luxembourg, et la société S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric HERREMANS, adresse professionnelle au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans. Pour la société ORCADE S.A. Référence de publication: 2012071821/17. (120102424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.
84707 Tishman Speyer Management (TSEC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Capital social: EUR 2.125.000,00. Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté. R.C.S. Luxembourg B 130.284. EXTRAIT Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 février 2012 que le mandat de la société suivante a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2012: - KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 103590. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Senningerberg, le 19 juin 2012. Pour extrait conforme ATOZ SA Aerogolf Center - Bloc B 1, Heienhaff L-1736 Sennigerberg Signature Référence de publication: 2012071915/22. (120102337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Nutrisearch S.A., Société Anonyme. Siège social: L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle. R.C.S. Luxembourg B 116.238. Im Jahre zwei tausend und zwölf, den zweiundzwanzigsten Mai. Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg); Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "Nutrisearch S.A.", mit Sitz zu L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 116.238. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den in Niederanven residierenden Notar Paul BETTINGEN, am 12. April 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1386 vom 19. Juli 2006. Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Régis LUX, Angestellter, berufsansässig in Luxemburg, 196, rue de Beggen. Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin und die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Isabell FELTEN, Angestellte, berufsansässig in Luxemburg, 196, rue de Beggen. Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest: I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist. II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung "ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden. III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten. IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte: Tagesordnung 1.- Beschluss den Gesellschaftssitz von L-1279 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg, nach L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle, zu verlegen und dementsprechend Artikel 2 der Satzung abzuändern 2.- Verschiedenes. Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: Erster Beschluss Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft nach L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle zu verlegen.
84708 Zweiter Beschluss Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor getätigte Abänderung beschließt die Generalversammlung der 3 ersten Sätze von Artikel 2 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben: " Art. 2. (3 erste Sätze). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden." Kosten Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 850,- EUR veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen. WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben. Gezeichnet: Régis LUX, Isabell FELTEN, Jean SECKLER. Enregistré à Grevenmacher, le 25 mai 2012. Relation GRE/2012/1852. Reçu soixante-quinze euros (75,- ). Le Receveur (signé): G. SCHLINK. Für gleichlautende Kopie erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Junglinster, den 20. Juni 2012. Référence de publication: 2012071808/56. (120102210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Picard Bondco, Société Anonyme. Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'eich. R.C.S. Luxembourg B 154.899. Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 17 avril 2012 En date du 17 avril 2012, le Conseil d'administration de la Société a décidé comme suit: - D'élire Monsieur Richard Brekelmans, Administrateur B de la Société, en tant que Président du Conseil d'administration, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée Générale Annuelle de l'an 2015 - D'élire Monsieur Johan Dejans, Administrateur B de la Société, en tant que Vice-Président du Conseil d'administration, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée Générale Annuelle de l'an 2015. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 19 juin 2012. Stijn CURFS Mandataire Référence de publication: 2012071823/17. (120102258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Clerc, Société Anonyme. R.C.S. Luxembourg B 111.831. Par la présente, je vous confirme ma décision de démissionner avec effet immédiat de mes fonctions d'administrateur de la société CLERC, immatriculée au RCS sous le numéro B 111 831. Bertrange, le 14 juin 2012. Christophe Deschamps. Référence de publication: 2012072612/9. (120102342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Sunflower S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 165.288. Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
84709 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 20 juin 2012. Référence de publication: 2012071878/10. (120102239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. The Malaspinian Fund SCA SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'investissement Spécialisé. Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal. R.C.S. Luxembourg B 141.252. Résolution prise par le Conseil d'administration de la SICAV-SIF en date du 24 octobre 2011 Le Conseil d'administration prend note que le réviseur d'entreprises agréé de la Société, Audit & Compliance S.à r.l., a fusionné avec PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Par conséquence, les comptes annuels de la Société pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2011 seront audités par la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son adresse au 400, rte d'esch, L-1014 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65477. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Référence de publication: 2012071913/14. (120102374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Prolifica International S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée. R.C.S. Luxembourg B 102.684. Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 21 JUIN 2012. Pour: PROLIFICA INTERNATIONAL S.A. Société anonyme Experta Luxembourg Société anonyme Mireille Wagner Référence de publication: 2012073260/15. (120103203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Compo Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Triton III MidCo 11 S.à r.l.). Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen. In the year two thousand and twelve, on fifth day of June. R.C.S. Luxembourg B 161.245. before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Triton III MidCo 11 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of seventy thousand euro (EUR 70,000.-), with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 3 June 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1936 of 23 August 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161.245 (the "Company"). The articles of incorporation were last amended following a notarial deed dated 27 December 2011 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 748 of 21 March 2012. The meeting was declared open at 06.06 pm by Mr Marc Frantz, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Florence Forster, lawyer, with professional address in Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Mr Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, with professional address in Luxembourg. The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following: (i) That the agenda of the meeting was the following:
84710 Agenda 1. To change the name of the Company to "Compo Co-Invest S.à r.l.". 2. To amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolution. 3. Miscellaneous. (ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. (iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed. (iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened. (v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda. (vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions: First resolution The Shareholders resolved to change the name of the Company to "Compo Co-Invest S.a r.l.". Second resolution In view of the above, the Shareholders resolved to amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolution, such paragraph being from now on read as follows: "The Company will exist under the name of "Compo Co-Invest S.à r.l. "." There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 06.21 pm. Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of inconsistencies between the English and the French text, the English text will prevail. The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the notary this original deed. Suit la traduction française du texte qui précède: L'an deux mille douze, le cinq juin, par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Triton III MidCo 11 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-), dont le siège social est au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 3 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1936 du 23 août 2011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 161.245 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 27 décembre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 748 du 21 Mars 2012. L'assemblée a été déclarée ouverte à 18.06 heures sous la présidence de Maître Marc Frantz, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Mlle Florence Forster, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. L'assemblée a choisi comme scrutateur M. Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le bureau ainsi constitué, le président a prié le notaire soussigné d'acter que: (i) l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant: Ordre du jour 1. Modification de la dénomination sociale de la Société en «Compo Co-Invest S.à r.l.». 2. Modification du troisième alinéa de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter la résolution proposée cidessus. 3. Divers. (ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. (iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte. (iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués. (v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour. (vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes: Première résolution Les Associés ont décidé de modifier la dénomination sociale de la Société en «Compo Co-Invest S.à r.l.». Deuxième résolution En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, les Associés ont décidé de modifier le troisième alinéa de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter la précédente résolution, cet alinéa ayant dorénavant la teneur suivante: «La Société existe sous la dénomination sociale «Compo Co-Invest S.à r.l.».» Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.21 heures. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ciavant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande aux mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra. Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. Signé: M. Frantz, F. Forster, M. Bertomeu-Savalle, M. Loesch. Enregistré à Remich, le 12 juin 2012, REM/2012/628. Reçu soixante-quinze euros. 75,00. Le Receveur (signé): P. MOLLING. Pour expédition conforme, Mondorf-les-Bains, le 20 juin 2012. 84711 Référence de publication: 2012071918/105. (120102377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Transalliance Europe, Société Anonyme. Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle de Riedgen. R.C.S. Luxembourg B 32.666. L'an deux mille douze, le sept mai. Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TRANSALLIANCE EUROPE", avec siège social à L-3451 Dudelange, Zone Industrielle de Riedgen, Ancien Site WSA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 32.666, constituée originairement sous la dénomination sociale de "S.C.L.", suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 236 du 16 juillet 1990, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN en date du 17 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 47 du 25 janvier 1996, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en "TRANSALLIANCE LUXEMBOURG S.A.", et dont la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 décembre 2001, l'extrait afférent ayant été publié audit Mémorial numéro 863 du 6 juin 2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du: - 31 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 148 du 9 février 2007, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en "TRANSALLIANCE EUROPE". - 7 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 785 du 1 er avril 2008. - 24 novembre 2011, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La séance est ouverte sous la présidence de Madame Isabell FELTEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 196, rue de Beggen.
84712 La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Regis LUX, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 196, rue de Beggen. Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées. La Présidente expose et l'assemblée constate: A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: Ordre du jour: 1. Elargissement de l'objet social et modification afférente de l'article 2 des statuts. 2. Divers. B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour. C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante: Unique résolution L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante: " Art. 2. La Société a pour objet: - toutes activités d'affrètement et de transport. - toute opération d'entreposage et la location de véhicules industriels. - l'achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties. Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes. La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social." Frais Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent euros. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. Signé: Isabell FELTEN, Regis LUX, Jean SECKLER. Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2012. Relation GRE/2012/1620. Reçu soixante-quinze euros (75,- ). Le Receveur (signé): G. SCHLINK. Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Junglinster, le 20 juin 2012. Référence de publication: 2012071926/78. (120102172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.
84713 Prolifica International S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée. R.C.S. Luxembourg B 102.684. Par décision de l assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 juin 2012, Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Madame Roselyne CANDIDO-MICHEL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et Monsieur Giacomo DI BARI, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg ont été nommés administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires, KOFFOUR S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et VALON S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg Leurs mandats s achèveront avec celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, à l issue de l assemblée générale annuelle de l an 2016. Luxembourg, le 21 juin 2012. Pour: PROLIFICA INTERNATIONAL S.A. Société anonyme Experta Luxembourg Société anonyme Référence de publication: 2012073259/19. (120103202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Shepherd Capital, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'investissement Spécialisé. Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet. R.C.S. Luxembourg B 151.295. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 juin 2012 a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.àr.l. en tant que réviseur d entreprises et ce jusqu à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 20 juin 2012. CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. Georges Beckene / Alain Thilmany Référence de publication: 2012073299/15. (120102837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Victoria Trading S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial. Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. R.C.S. Luxembourg B 43.124. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 avril 2012 Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, prise lors du Conseil d'administration du 15 mars 2012, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, démissionnaire. Pour la société VICTORIA TRADING S.A., SPF Référence de publication: 2012071943/12. (120102423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Way LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen. R.C.S. Luxembourg B 151.888. Les statuts coordonnés au 5 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
84714 Marc Loesch Notaire Référence de publication: 2012071950/11. (120102179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. 1798 AOG Energy Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'investissement Spécialisé. Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer. R.C.S. Luxembourg B 150.358. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée Générale Ordinaire en date du 15 juin 2012 En date du 15 juin 2012, l'assemblée Générale Ordinaire a décidé: - de renouveler les mandats de Monsieur Alexandre Meyer, Monsieur Jean-Claude Ramel et Monsieur Patrick Zurstrassen et en qualité d'administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013; - de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité réviseur d'entreprises agréé pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale de 2013. Luxembourg, le 19 juin 2012. Pour extrait sincère et conforme Pour 1798 AOG Energy Fund Référence de publication: 2012071966/17. (120102314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. POFI Engineering S.A., Société Anonyme. Siège social: L-4394 Pontpierre, 26, rue de l'ecole. R.C.S. Luxembourg B 118.719. Extrait de résolution de l'assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2012 Les actionnaires de la société POFI ENGINEERING S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai, ont décidé à l'unanimité, de prendre la résolution suivante: L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège de la société de Pontpierre, 19 rue de Luxembourg et de fixer la nouvelle adresse à L-4394 Pontpierre, 26, rue de l'école. Pour extrait conforme Pontpierre, le 31 mai 2012. Référence de publication: 2012073255/14. (120102729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. 3 C Investments & Partners S.A., Société Anonyme. Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle. R.C.S. Luxembourg B 101.864. Le siège social du commissaire, AUDIEX S.A., est désormais 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 18 juin 2012. Référence de publication: 2012071973/11. (120102232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. CLERC, Compagnie Luxembourgeoise d'expertise et de Révision Comptable, Société Anonyme. R.C.S. Luxembourg B 92.376. Par la présente, je vous confirme ma décision de démissionner avec effet immédiat de mes fonctions d'administrateur de la société COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'EXPERTISE ET DE REVISION COMPTABLE, en abrégé CLERC, Immatriculée au RCS sous le numéro B 92 376. Bertrange, le 14 juin 2012. Christophe Deschamps. Référence de publication: 2012072610/10. (120102339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012.
84715 Grant Thornton Révision et Conseils S.A., Société Anonyme. Siège social: L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean-Baptiste Esch. R.C.S. Luxembourg B 22.668. Par la présente, je vous confirme ma décision de démissionner avec effet immédiat de mes fonctions d'administrateur de la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., immatriculée au RCS sous le numéro B 22 668. Bertrange, le 14 juin 2012. Christophe Deschamps. Référence de publication: 2012072618/10. (120102336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Kingsbridge Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Capital social: EUR 12.500,00. Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy. R.C.S. Luxembourg B 134.810. Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 mai 2012 Monsieur Stefan Henrich, employé privé, né le 25 mars 1967 à Frankfurt (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 42, Berkeley Square, W1J 5AW London, Royaume-Uni, a été nommé gérant de la Société avec effet au 22 mai 2012 et pour une durée indéterminée (en remplacement de Monsieur Mathias Hink, démissionnaire). Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Pour Kingsbridge Finance S.à r.l. Signature Un mandataire Référence de publication: 2012072621/17. (120102228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Succursale Gaz Métro International, Succursale d'une société de droit étranger. Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann. R.C.S. Luxembourg B 169.498. STATUTS DE MODIFICATION Ce formulaire s'adresse à toute société par actions qui désire déposer des statuts de modification, Il s'adresse également au conseil d'administration de toute société qui désire corriger des irrégularités, des illégalités ou des erreurs non manifestes contenues dans ses statuts. Veuillez lire les renseignements aux pages 3 et 4 avant de remplir ce formulaire. 1. Identification de la société. Nom Inscrivez le nom de la société ou sa désignation numérique. 9264-5944 QUÉBEC INC. 2. Modification des statuts. 2.1 Nom Inscrivez le nouveau nom de la société et sa version dans une autre langue, s'il y a lieu, N'inscrivez rien si vous demandez une désignation numérique au lieu d'un nom. Cochez la case appropriée, - Nous demandons une désignation numérique au lieu d'un nom. - Nous demandons un nouveau nom et nous confirmons que nous avons pris des moyens raisonnables pour nous assurer que le nom choisi est conforme à la loi. 2.2 Modifications apportées aux statuts de fa société Voir l'annexe ci-jointe. 2.3 Date d'entrée en vigueur Inscrivez la date d'entrée en vigueur si elle est postérieure à celle de la réception des statuts, (Pour les statuts qui ne sont pas visés à la section 3.) 2.4 Heure d'entrée en vigueur Inscrivez l'heure d'entrée en vigueur, le cas échéant. - heures minutes - avant-midi - après-midi
84716 (Pour les statuts qui ne sont pas visés à la section 3.) 3. Correction des statuts. 3.1 Déclaration de l'administrateur ou du dirigeant autorisé Je déclare (Cochez la ou les cases appropriées.) - que la demande de correction risque de porter atteinte aux droits des créanciers, - Dans ce cas, joignez une copie du jugement autorisant la correction. - que la demande ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers. - que la demande risque de porter atteinte aux droits des actionnaires. - Dans ce cas, joignez une copie du jugement autorisant la correction ou une copie de la résolution adoptée par tous les actionnaires dont les droits seraient affectés par la correction. - que la demande ne risque pas de porter atteinte aux droits des actionnaires, 3.2 Corrections apportées aux statuts de la société 3.3 Date d'entrée en vigueur 3.4 Heure d'entrée en vigueur (s'il y a lieu) - heures minutes - avant-midi - après-midi (La correction rétroagit à la date et à l'heure, s'il y a lieu, du certificat accompagnant les statuts que l'on corrige à moins que les présents statuts ou le jugement ne prévoient une date et une heure ultérieures à celles-ci, le cas échéant.) Signature Administrateur ou du dirigeant autorisé Annexe 1 The authorized capital of the Corporation is amended by redesignating the only class of shares currently authorized as Common Shares and authorizing the issuance of an unlimited number of Preference Shares, having the right, privileges and conditions set forth below. Common shares 1. Voting Rights. Each holder of common shares shall be entitled to receive notice of and to attend all meetings of shareholders of the Corporation and to vote thereat, except meetings at which only holders of a specified class of shares (other than common shares) or specified series of shares are entitled to vote. At all meetings of which notice must be given to the holders of the common shares, each holder of common shares shall be entitled to one vote in respect of each common share held by such holder. 2. Dividends. The holders of the common shares shall be entitled, subject to the rights, privileges, restrictions and conditions attaching to any other class of shares of the Corporation, to receive any dividend declared by the Corporation. 3. Liquidation, Dissolution or Winding-up. The holders of the common shares shall be entitled, subject to the rights, privileges, restrictions and conditions attaching to any other class of shares of the Corporation, to receive the remaining property of the Corporation on a liquidation, dissolution or winding-up of the Corporation, whether voluntary or involuntary, or on any other return of capital or distribution of assets of the Corporation among its shares for the purpose of winding up its affairs. Preference shares 1. Definitions. With respect to the Preference Shares, the following terms shall have the meanings ascribed to them below: (a) "Act" means the Business Corporations Act (Québec). (b) "Redemption Price" of a Preference Share means the quotient obtained by dividing (A) the difference between (i) the amount in United States' dollars which is the sum of all amounts, calculated in United States dollars at the time of each addition, added to the capital account maintained or deemed to be maintained by the Corporation for its Preference Shares, and (ii) the amount in United States' dollars which is the sum of all amounts, calculated in United States dollars at the time of each subtraction, subtracted from the capital account maintained or deemed to be maintained by the Corporation for its Preference Shares, by (B) the number of Preference Shares issued at the time of any determination thereof. 2. Dividends. The holders of the Preference Shares shall not be entitled to any dividends and the Corporation shall not declare any dividend on the Preference Shares. 3. No Voting Rights. Except as otherwise provided in the Act, the holders of the Preference Shares shall not be entitled to receive notice of, or to attend or to vote at, any meeting of the shareholders of the Corporation. 4. Liquidation, Dissolution or Winding-up. In the event of the liquidation, dissolution or winding-up of the Corporation, whether voluntary or involuntary, or any other return of capital or distribution of assets of the Corporation among its shareholders for the purpose of winding up its affairs, the holders of the Preference Shares shall be entitled to receive in respect of each such share, before any distribution of any part of the assets of the Corporation among the holders of the
84717 common shares and any other shares of the Corporation ranking junior to the Preference Shares, an amount equal to the Redemption Price, After payment to the holders of the Preference Shares of the amount so payable to such holders as herein provided, the holders of the Preference Shares shall not be entitled to share in any further distribution of the property or assets of the Corporation. 5. Redemption at the Option of the Corporation. Subject to the Act, the Corporation shall, at its option, be entitled to redeem at any time or times all or any part of the Preference Shares registered in the name of any holder of any such Preference Shares on the books of the Corporation with or without the consent of such holder by giving notice in writing to such holder, (unless such notice is waived by the holder) specifying: (a) that the Corporation desires to redeem all or any part of the Preference Shares registered in the name of such holder; (b) if part only of the Preference Shares registered in the name of such holder is to be redeemed, the number thereof to be so redeemed; (c) the Redemption Price; (d) the business day (in this Section 5 referred to as the "Redemption Date") on which the Corporation desires to redeem such Preference Shares. The Redemption Date shall be the date that is one business day after the date on which the notice is given by the Corporation or such other date as the Corporation and such holder may agree; and (e) the place of redemption. The Corporation shall, on the Redemption Date, subject to Section 7 below, redeem such Preference Shares by paying to such holder an amount equal to the aggregate Redemption Price (less any tax required to be withheld by the Corporation) on presentation and surrender of the certificate(s) for the Preference Shares so called for redemption at such place as may be specified in such notice. The certificate(s) for such Preference Shares shall thereupon be cancelled and the Preference Shares represented thereby shall thereupon be redeemed. Payment of the aggregate Redemption Price for the Preference Shares to be redeemed shall be made, at the option of the Corporation, (i) by delivery to such holder of a cheque of the Corporation payable at par at any branch in Canada of the Corporation's bankers; (ii) by wire transfer by the Corporation to the holder of the Preference Shares; or (Hi) by a demand note with a principal amount equal to the aggregate Redemption Price for the Preference Shares to be redeemed. From and after the Redemption Date, the holder of such Preference Shares shall not be entitled to exercise any of the rights of holders of Preference Shares in respect thereof unless payment of the Redemption Price is not made on the Redemption Date, or on presentation and surrender of the certificate(s) for the Preference Shares so called for redemption, whichever is later, in which case the rights of the holder of the Preference Shares shall remain unaffected until payment in full of the Redemption Price. Where at any time, some, but not all, of such Preference Shares are to be redeemed, the Preference Shares to be redeemed shall be selected by lot in such manner as the board of directors determines, or as nearly as may be in proportion to the number of Preference Shares registered in the name of each holder, or in such other manner as the board of directors determines. 6. Redemption at the Option of the Holder. Subject to the Act, a holder of any Preference Shares shall be entitled to require the Corporation to redeem at any time or times any Preference Shares registered in the name of such holder on the books of the Corporation by tendering to the Corporation at its registered office a share certificate representing the Preference Shares which the holder desires to have the Corporation redeem together with a request in writing (in this Section 6 referred to as the "Redemption Demand"), (unless such request is waived by the Corporation) specifying: (a) that the holder desires to have the Preference Share represented by such certificate redeemed by the Corporation; (b) if part only of the Preference Shares registered in the name of such holder is to be redeemed, that number thereof to be so redeemed; and (c) the business day (in this Section 6 referred to as the "Redemption Date") on which the holder desires to have the Corporation redeem such Preference Shares. The Redemption Date shall be the date that is one business day after the date on which the Redemption Demand is tendered to the Corporation or such other date as the holder and the Corporation may agree. The Corporation shall, on the Redemption Date, subject to Section 7 below, redeem all Preference Shares required to be redeemed by paying to such holder an amount equal to the aggregate Redemption Price (less any tax required to be withheld by the Corporation) on presentation and surrender of the certificate(s) for the Preference Shares to be so redeemed at the registered office of the Corporation. The certificate(s) for such Preference Shares shall thereupon be cancelled and the Preference Shares represented thereby shall thereupon be redeemed. Payment of the aggregate Redemption Price for the Preference Shares to be redeemed shall be made, at the option of the Corporation, (i) by delivery to such holder of a cheque of the Corporation payable at par at any branch in Canada of the Corporation's bankers; (ii) by wire transfer by the Corporation to the holder of the Preference Shares; or (iii) by a demand note with a principal amount equal to, the aggregate Redemption Price for the Preference Shares to be redeemed. From and after the Redemption Date, the holder of such Preference Shares shall not be entitled to exercise any of the rights of holders of Preference Shares in respect thereof unless payment of the said Redemption Price is not made on the Redemption Date, in which case the rights of the holder of the Preference Shares shall remain unaffected until payment in full of the Redemption Price.
84718 7. Partial Redemption. If less than all Preference Shares represented by a certificate are redeemed, the holder shall be entitled to receive, at the expense of the Corporation, a new certificate representing the Preference Shares which have not been redeemed. Référence de publication: 2012071876/145. (120102037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Memphis Engineering Corporation S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen. R.C.S. Luxembourg B 59.294. Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Référence de publication: 2012073185/10. (120103606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Memphis Engineering Corporation S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen. R.C.S. Luxembourg B 59.294. Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Référence de publication: 2012073186/10. (120103607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. New Pearl S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Capital social: USD 15.700,00. Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey. R.C.S. Luxembourg B 169.461. Signature. Signature. Il est porté à la connaissance de tiers qu en date du 29 mai 2012, Orangefield Trust Luxembourg S.A., l Associé Unique de la société émargée, a transféré les 15,700 parts sociales qu elle détenait dans New Pearl S.à r.l à Stichting New Pearl ayant son siège social au 140 Teleportboulevard, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands. Pour la société Un mandataire Référence de publication: 2012073198/13. (120103239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Property Partners S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel. R.C.S. Luxembourg B 72.368. Extrait des résolutions de l assemblée générale ordinaire du 15 mai 2012 Nominations d administrateurs, de commissaire aux comptes et de reviseur d entreprises L assemblée a décidé: 1/ De renouveler le mandat d administrateur des personnes suivantes jusqu à l Assemblée Générale Ordinaire de 2018: - Monsieur Vincent Bechet, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg - Monsieur Marc Baertz, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg - Monsieur Frank Rosenbaum, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg - Madame Angélique Sabron, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg - Monsieur Stéphane Terver, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg. 2/ De renouveler le mandat de Monsieur Paul Mathes, résidant 22, rue de Larochette, L-7640 Christnach, en tant que Commissaire aux Comptes jusqu à l Assemblée Générale Ordinaire de 2018.
84719 3/ De désigner la société BDO Audit S.A., établie et ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, comme réviseur d entreprises de la société. Son mandat expirera à l issue de l Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de 2012. Référence de publication: 2012071828/21. (120102488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Miplaka S.A. - SPF, Société Anonyme. Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen. R.C.S. Luxembourg B 54.220. EXTRAIT Il résulte de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social en date du 1 er juin 2012 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 1 er juin 2012. Référence de publication: 2012073187/12. (120103295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. NasyaJet S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre. R.C.S. Luxembourg B 128.104. Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg. Signature. Référence de publication: 2012073195/10. (120102949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Northridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen. R.C.S. Luxembourg B 123.806. Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Signature. Référence de publication: 2012073201/10. (120102852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Pa.Fi. France, Société Anonyme. Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri. R.C.S. Luxembourg B 42.618. Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Société Européenne de Banque S.A. Société Anonyme Banque domiciliataire Signatures Référence de publication: 2012073245/13. (120103314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Najis Real Estate S.A., Société Anonyme. Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. R.C.S. Luxembourg B 93.347. Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
84720 Luxembourg, le 31 mai 2012. POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Signatures Référence de publication: 2012073203/12. (120102963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Napos Trading Company S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades. R.C.S. Luxembourg B 15.359. Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 16 mai 2012. SG AUDIT SARL Référence de publication: 2012073204/11. (120103408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. New European Corporation SA, Société Anonyme. Siège social: L-1724 Luxembourg, 15A, boulevard du Prince Henri. R.C.S. Luxembourg B 137.159. Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. NEW EUROPEAN CORPORATION S.A. Société Anonyme Référence de publication: 2012073208/11. (120102730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. NGF S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen. R.C.S. Luxembourg B 133.735. EXTRAIT Il résulte de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social en date du 1 er juin 2012 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 1 er juin 2012. Référence de publication: 2012073209/12. (120103264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012. Property Partners Residential, Société Anonyme. Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel. R.C.S. Luxembourg B 154.071. Extrait des résolutions du conseil d'administration du 29 mai 2012 ELECTION DU BUREAU, MANDAT D'ADMINISTRATEUR DELEGUE Le Conseil d'administration a décidé: 1/ De nommer Monsieur Vincent Bechet, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, comme Président du Conseil jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire de 2018. 2/ De reconduire Monsieur Vincent Bechet, résidant professionnellement au 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en tant qu'administrateur Délégué de la société jusqu'à l'assemblée Générale de 2018. Référence de publication: 2012071841/14. (120102487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2012. Editeur: Imprimeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck