Gazette royale. The Royal Gazette. Notice to Readers. Avis aux lecteurs. Orders in Council. Décrets en conseil



Documents pareils
Gazette royale. The Royal Gazette. Avis aux lecteurs. Notice to Readers. Proclamations. Proclamations

Les installations accréditées au complet en LAI dans la région Atlantique Paysagistes 16 avril, 2015

Liste des intervenants de Travail sécuritaire NB Septembre 2014

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, À jour au 30 août Last amended on December 12, 2013

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

Short-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION

Crisis Lines/Emergency Numbers Lignes d écoute téléphonique/ Numéros d urgence

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015

Order Assigning to the Minister of the Environment, the Administration, Management and Control of Certain Public Lands

If the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to:

INVESTMENT REGULATIONS R In force October 1, RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R En vigueur le 1 er octobre 2001

Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations

Special Operating Agencies Designation Regulation, amendment. Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des organismes de service spécial

de stabilisation financière

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION

AIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES

Resident Canadian (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION

Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Practice Direction. Class Proceedings

Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations

TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R

COLLEGE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS

Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION

Bill 69 Projet de loi 69

LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT

Material Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION

AMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32

Form of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations

Interest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION

Air Transportation Tax Order, Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION

Railway Operating Certificate Regulations. Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer CODIFICATION CONSOLIDATION

PROJET DE LOI. An Act to Amend the Employment Standards Act. Loi modifiant la Loi sur les normes d emploi

RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5

CONVENTION DE STAGE TYPE STANDART TRAINING CONTRACT

POLICY: FREE MILK PROGRAM CODE: CS-4

Bill 204 Projet de loi 204

1 400 HKD / year (Season : 21/09/ /06/2016)

Filed December 22, 2000

Life Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION

CONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI

Réunion du conseil d administration de la Commission de services régionaux de Kent

INSCRIPTION MASTER / MASTER S APPLICATION

Société d assurance-dépôts des

Enquête Catalyst 2011 : Les femmes membres de conseils d administration selon le classement - Financial Post 500

Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations

INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.

PROJET DE LOI. An Act Respecting the Revised Statutes, Loi concernant les Lois révisées de 2014

CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015

General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION

LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002

Réunion du conseil d administration de la Commission de services régionaux de Kent. le 20 novembre h30 Édifice municipal de Saint-Louis

PRiCEWATERHOUSGOPERS 0

Gazette royale. The Royal Gazette. Notice to Readers. Avis aux lecteurs. Décrets en conseil. Orders in Council

VILLE DE MONTRÉAL CITY OF MONTREAL. Arrondissement Kirkland Borough

Ottawa,, 2009 Ottawa, le 2009

Coordonnées de l administrateur SEDI

Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Gazette royale. The Royal Gazette. Notice to Readers. Avis aux lecteurs. Décrets en conseil. Orders in Council

Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION

D R A F T (a work in progress destined to always be incomplete, the way all dictionaries are, because people and languages constantly evolve )

Gazette royale. The Royal Gazette. Notice to Readers. Avis aux lecteurs. Loi sur les corporations commerciales. Business Corporations Act

Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations

ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION / UNIVERSITY OR COLLEGE:

(télécopieur / fax) (adresse électronique / address)

12 n o is a S n o s a e s 2011 F o u n d i n g P a r t n e r / P a r t e n a i r e F o n d a t e u r

PRÉSENTÉ AU FRONT DES INDÉPENDANTS DU CANADA PAR ANNE-MARIE DUBOIS

Vos élèves, nos étudiants!

Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations

PART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11

Import Allocation Regulations. Règlement sur les autorisations d importation CONSOLIDATION CODIFICATION

BLUELINEA ,00 EUR composé de actions de valeur nominale 0,20 EUR Date de création : 17/01/2006

FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015

Nouveautés printemps 2013

Export Permit (Steel Monitoring) Regulations. Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) CONSOLIDATION CODIFICATION

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION

The Royal Gazette. Gazette royale. Avis aux lecteurs. Notice to Readers. Assemblée législative. Legislative Assembly

Francoise Lee.

Gazette royale. The Royal Gazette. Notice to Readers. Avis aux lecteurs. Bureau de la directrice générale des élections

CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION

Gazette royale. The Royal Gazette. Avis Important. Important Notice. Notice to Readers. Avis aux lecteurs

AUDIT COMMITTEE: TERMS OF REFERENCE

BILL 13 PROJET DE LOI 13. certains droits relatifs à l approvisionnement en bois et à l aménagement forestier

Partageons nos similarités, fêtons nos différences. Soyez engagés. Guide d orientation à l intention des nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick

Application Form/ Formulaire de demande

UNIVERSITY OF MALTA FACULTY OF ARTS. French as Main Area in an ordinary Bachelor s Degree

Dates and deadlines

86 rue Julie, Ormstown, Quebec J0S 1K0

Instructions Mozilla Thunderbird Page 1

APPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder

Quick Start Guide This guide is intended to get you started with Rational ClearCase or Rational ClearCase MultiSite.

Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement. Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act

that the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on

has brought a motion to change the order of Justice, dated. the agreement between you and (name of party bringing this motion), dated.

Paxton. ins Net2 desktop reader USB

Transcription:

The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick ISSN 1714-9428 Vol. 174 Wednesday, February 3, 2016 / Le mercredi 3 février 2016 109 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator. Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale. Orders in Council DECEMBER 17, 2015 2015-287 1. Under subsections 30(2) and 30(5) of the Mental Health Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Jean B. Plourde, Dalhousie, New Brunswick, as chairman of the Mental Health Review Board for the North (Zones 4, 5 and 6), for a term of one year, effective December 20, 2015. Décrets en conseil LE 17 DÉCEMBRE 2015 2015-287 1. En vertu des paragraphes 30(2) et 30(5) de la Loi sur la santé mentale, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Jean B. Plourde, de Dalhousie (Nouveau- Brunswick), président de la commission de recours de la santé mentale pour le Nord (zones 4, 5 et 6), pour un mandat d un an, à compter du 20 décembre 2015.

The Royal Gazette February 3, 2016 110 Gazette royale 3 février 2016 2. Under subsections 30(3) and 30(5) of the Mental Health Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Pierre Godin, Petit-Rocher, New Brunswick, as an alternate member of the Mental Health Review Board for the North (Zones 4, 5 and 6), for a term of three years, effective December 17, 2015. Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor DECEMBER 17, 2015 2015-288 Under subsections 30(3) and 30(5) of the Mental Health Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Thérèse Roy, Dieppe, New Brunswick, as an alternate member of the Mental Health Review Board for the South (Zones 1, 2, 3 and 7), for a term of three years, effective December 17, 2015. Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor DECEMBER 17, 2015 2015-289 Under paragraph 9(3)(e) and subsection 11(2) of the New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Zach Painter, Woodstock, New Brunswick, as the Student Member of the Board of Governors of the New Brunswick Community College, effective December 17, 2015, for a term to expire October 6, 2017. Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor DECEMBER 17, 2015 2015-291 1. Under subsections 11(2), 12(7) and 13(1) of the Service New Brunswick Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Roberta Dugas, Caraquet, New Brunswick, as a member of the Board of Directors of Service New Brunswick, effective December 17, 2015 for a term to expire October 1, 2017. 2. Under subsection 11(2) and 13(1) of the Service New Brunswick Act and section 26 of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in Council revokes paragraph 2(b) of Order in Council 2015-218 dated September 23, 2015. Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor 2. En vertu des paragraphes 30(3) et 30(5) de la Loi sur la santé mentale, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Pierre Godin, de Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick), membre suppléant de la commission de recours de la santé mentale pour le Nord (zones 4, 5 et 6), pour un mandat de trois ans, à compter du 17 décembre 2015. La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau LE 17 DÉCEMBRE 2015 2015-288 En vertu des paragraphes 30(3) et 30(5) de la Loi sur la santé mentale, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Thérèse Roy, de Dieppe (Nouveau-Brunswick), membre suppléante de la commission de recours de la santé mentale pour le Sud (zones 1, 2, 3 et 7), pour un mandat de trois ans, à compter du 17 décembre 2015. La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau LE 17 DÉCEMBRE 2015 2015-289 En vertu de l alinéa 9(3)e) et du paragraphe 11(2) de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Zach Painter, de Woodstock (Nouveau-Brunswick), membre étudiant du conseil des gouverneurs du New Brunswick Community College, à compter du 17 décembre 2015, pour un mandat prenant fin le 6 octobre 2017. La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau LE 17 DÉCEMBRE 2015 2015-291 1. En vertu des paragraphes 11(2), 12(7) et 13(1) de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Roberta Dugas, de Caraquet (Nouveau- Brunswick), membre du conseil d administration de Services Nouveau-Brunswick, à compter du 17 décembre 2015, pour un mandat prenant fin le 1 er octobre 2017. 2. En vertu des paragraphes 11(2) et 13(1) de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick et de l article 26 de la Loi d interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil révoque l alinéa 2b) du décret en conseil 2015-218 pris le 23 septembre 2015. La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

The Royal Gazette February 3, 2016 111 Gazette royale 3 février 2016 DECEMBER 17, 2015 2015-292 1. Under section 6 of the Municipal Elections Act and section 26 of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in Council revokes (a) section 2 of Order in Council 2012-30 dated February 1, 2012; (b) section 1 of Order in Council 2013-86 dated March 20, 2013; and (c) section 2 of Order in Council 2013-272 dated September 4, 2013. 2. Under section 6 of the Municipal Elections Act, section 36.3 of the Education Act and section 11 of New Brunswick Regulation 2012-7, the Board Regulation - Regional Health Authorities Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation of the Municipal Electoral Officer, appoints the following persons as municipal returning officers, effective immediately for the 2016 quadrennial elections, as well as any byelections for municipalities and rural communities that may be required in their respective region from the date hereof until their appointment is revoked: (a) Mel Parker, Campbellton, New Brunswick, for: (i) Region M01 (Restigouche): Atholville, Balmoral, Campbellton, Charlo, Dalhousie, Eel River Crossing, Kedgwick, Saint-Quentin and Tide Head; (ii) School Districts: Anglophone North, subdistricts 1 and 2 (part), Francophone Nord-est, subdistricts 1 and 2 (part), Francophone Nord-ouest, subdistricts 5 and 6; and (iii) Health Regions: A (Vitalité), subregions A4 (part), A5 and A6 (part); (b) Mark Guindon, Bathurst, New Brunswick, for: (i) Region M02 (Bathurst and Area): Bathurst, Belledune, Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, and Pointe- Verte; (ii) School Districts: Anglophone North, subdistricts 2 (part) and 3 (part), Francophone Nord-est, subdistricts 2 (part), 3, 4, and 5 (part); and (iii) Health Regions: A (Vitalité), subregions A6 (part) and A7 (part); (c) Weldon McLaughlin, Pointe-A-Bouleau, New Brunswick, for: (i) Region M03 (Acadian Peninsula): Bas-Caraquet, Bertrand, Caraquet, Grande-Anse, Lamèque, Le Goulet, Maisonnette, Paquetville, Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Saint-Isidore, Saint-Léolin, Shippagan, and Tracadie; (ii) School Districts: Anglophone North, subdistricts 3 (part) and 4 (part), Francophone Nord-est, subdistricts 5 (part), 6, 7, and 8; and (iii) Health Regions: A (Vitalité), subregions A7 (part) and A8, B (Horizon), subregion B7 (part); (d) Cyril Donahue, Miramichi, New Brunswick, for: LE 17 DÉCEMBRE 2015 2015-292 1. En vertu de l article 6 de la Loi sur les élections municipales et de l article 26 de la Loi d interprétation, le lieutenantgouverneur en conseil révoque a) l article 2 du décret en conseil 2012-30 pris le 1 er février 2012; b) l article 1 du décret en conseil 2013-86 pris le 20 mars 2013; et c) l article 2 du décret en conseil 2013-272 pris le 4 septembre 2013. 2. En vertu de l article 6 de la Loi sur les élections municipales, de l article 36.3 de la Loi sur l éducation et de l article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-7, Règlement sur le conseil Loi sur les régies régionales de la santé, le lieutenantgouverneur en conseil, sur la recommandation du directeur des élections municipales, nomme les personnes suivantes directeurs du scrutin municipal pour l élection quadriennale de 2016 ainsi que pour toute élection complémentaire pour les municipalités et les communautés rurales qui pourraient être nécessaires dans leur région respective, leur nomination entrant en vigueur immédiatement et prenant fin à la révocation de celle-ci : a) Mel Parker, de Campbellton (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M01 (Restigouche): Atholville, Balmoral, Campbellton, Charlo, Dalhousie, Eel River Crossing, Kedgwick, Saint-Quentin et Tide Head; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone North, sous-districts 1 et 2 (en partie); le district scolaire Francophone Nord-Est, sous-districts 1 et 2 (en partie); le district scolaire Francophone Nord-Ouest, sous-districts 5et 6; et (iii) Régions de la santé : la région de la santé A (Vitalité), sous-régions A4 (en partie), A5 et A6 (en partie); b) Mark Guindon, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M02 (Bathurst et région) : Bathurst, Belledune, Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe- Verte; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone North, sous-districts 2 (en partie) et 3 (en partie); le district scolaire Francophone Nord-Est, sous-districts 2 (en partie), 3, 4 et 5 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé A (Vitalité), sous-régions A6 (en partie) et A7 (en partie); c) Weldon McLaughlin, de Pointe-à-Bouleau (Nouveau- Brunswick), pour : (i) la région M03 (Péninsule acadienne) : Bas-Caraquet, Bertrand, Caraquet, Grande-Anse, Lamèque, Le Goulet, Maisonnette, Paquetville, Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Saint-Isidore, Saint-Léolin, Shippagan et Tracadie; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone North, sous-districts 3 (en partie) et 4 (en partie); le district scolaire Francophone Nord-Est, sous-districts 5 (en partie), 6, 7 et 8; et (iii) Régions de la santé : la région de la santé A (Vitalité), sous-régions A7 (en partie) et A8; la région de la santé B (Horizon), sous-région B7 (en partie); d) Cyril Donahue, de Miramichi (Nouveau-Brunswick), pour :

The Royal Gazette February 3, 2016 112 Gazette royale 3 février 2016 (i) Region M04 (Northumberland): Blackville, Doaktown, Miramichi, Neguac, and Upper Miramichi; (ii) School Districts: Anglophone North, subdistricts 4 (part), 5 (part), 6 and 7 (part), Anglophone West, subdistrict 10 (part), Francophone Nord-est, subdistrict 9, Francophone Sud, subdistrict 1 (part), 2 (part), and 10 (part); (iii) Health Regions: A (Vitalité), subregion A1 (part), B (Horizon), subregions B1 (part), B6 (part), B7 (part) and B8 (part); (e) Simmone Belliveau, Baie-de-Bouctouche, New Brunswick, for: (i) Region M05 (Kent-Westmorland): Beaubassin East/ Beaubassin-est, Bouctouche, Cap-Pelé, Cocagne, Rexton, Richibucto, Rogersville, Saint-Antoine, Saint- Louis-de-Kent, and Shediac; (ii) School Districts: Anglophone East, subdistricts 1 (part) and 6 (part), Anglophone North, subdistricts 5 (part) and 7 (part), Francophone Sud, subdistricts 1 (part), 2 (part), 3 and 4 (part); and (f) (iii) Health Regions: A (Vitalité), subregion A1 (part), B (Horizon), subregions B1 (part) and B8 (part); O Neil Arseneau, Dieppe, New Brunswick, for: (i) Region M06 (Albert-Westmorland): Alma, Dieppe, Dorchester, Hillsborough, Memramcook, Petitcodiac, Port Elgin, Riverside-Albert, Riverview, Sackville, and Salisbury; (ii) School Districts: Anglophone East, subdistricts 2, 3, 7, 8 and 9 (part), Francophone Sud, subdistricts 4 (part), 5, 6 and 8 (part); and (iii) Health Regions: A (Vitalité), subregions A1 (part) and A2 (part), B (Horizon), subregions B1 (part) and B2 (part); (g) Donna Gauthier, Riverview, New Brunswick, for: (i) Region M07 (Moncton): Moncton; (ii) School Districts: Anglophone East, subdistricts 1 (part), 4, 5, 6 (part) and 9 (part), Francophone Sud, subdistricts 7 and 8 (part); and (iii) Health Regions: A (Vitalité), subregion A2 (part), B (Horizon), subregion B2 (part); (h) Richard Mackie, Quispamsis, New Brunswick, for: (i) Region M08 (King-Queens): Cambridge-Narrows, Hampton, Norton, Quispamsis, Rothesay, St. Martins, Sussex, and Sussex Corner; (ii) School Districts: Anglophone South, subdistricts 3 (part), 7 (part), 8, 9, 10 and 11, Anglophone West, subdistrict 11 (part), Francophone Sud, subdistricts 9 (part) and 10 (part); and (i) la région M04 (Northumberland) : Blackville, Doaktown, Miramichi, Neguac et Upper Miramichi; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone North, sous-districts 4 (en partie), 5 (en partie), 6 et 7 (en partie); le district scolaire Anglophone West, sous-district 10 (en partie); le district scolaire Francophone Nord-Est, sous-district 9; le district scolaire Francophone Sud, sousdistricts 1 (en partie), 2 (en partie) et 10 (en partie); (iii) Régions de la santé : la région de la santé A (Vitalité), sous-région A1 (en partie); la région de la santé B (Horizon), sous-régions B1 (en partie), B6 (en partie), B7 (en partie) et B8 (en partie); e) Simmone Belliveau, de Baie-de-Bouctouche (Nouveau- Brunswick), pour : (i) la région M05 (Kent-Westmorland) : Beaubassin East/Beaubassin-Est, Bouctouche, Cap-Pelé, Cocagne, Rexton, Richibucto, Rogersville, Saint-Antoine, Saint- Louis-de-Kent et Shediac; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone East, sous-districts 1 (en partie) et 6 (en partie); le district scolaire Anglophone North, sous-districts 5 (en partie) et 7 (en partie); le district scolaire Francophone Sud, sousdistricts 1 (en partie), 2 (en partie), 3 et 4 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé A (Vitalité), sous-région A1 (en partie); la région de la santé B (Horizon), sous-régions B1 (en partie) et B8 (en partie); f) O Neil Arseneau, de Dieppe (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M06 (Albert-Westmorland) : Alma, Dieppe, Dorchester, Hillsborough, Memramcook, Petitcodiac, Port Elgin, Riverside-Albert, Riverview, Sackville et Salisbury; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone East, sous-districts 2, 3, 7, 8 et 9 (en partie); le district scolaire Francophone Sud, sous-districts 4 (en partie), 5, 6 et 8 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé A (Vitalité), sous-régions A1 (en partie) et A2 (en partie); la région de la santé B (Horizon), sous-régions B1 (en partie) et B2 (en partie); g) Donna Gauthier, de Riverview (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M07 (Moncton) : Moncton; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone East, sous-districts 1 (en partie), 4, 5, 6 (en partie) et 9 (en partie); le district scolaire Francophone Sud, sousdistricts 7 et 8 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé A (Vitalité), sous-région A2 (en partie); la région de la santé B (Horizon), sous-région B2 (en partie); h) Richard Mackie, de Quispamsis (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M08 (King-Queens) : Cambridge-Narrows, Hampton, Norton, Quispamsis, Rothesay, St. Martins, Sussex et Sussex Corner; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone South, sous-districts 3 (en partie), 7 (en partie), 8, 9, 10 et 11; le district scolaire Anglophone West, sous-district 11 (en partie); le district scolaire Francophone Sud, sousdistricts 9 (en partie) et 10 (en partie); et

The Royal Gazette February 3, 2016 113 Gazette royale 3 février 2016 (i) (iii) Health Regions: B (Horizon), subregions B3 (part), B4 (part) and B6 (part); Richard Thorne, Hampton, New Brunswick, for: (i) Region M09 (Saint John): Grand Bay-Westfield, and Saint John; (ii) School Districts: Anglophone South, subdistricts 2 (part), 3 (part), 4, 5, 6 and 7 (part), Francophone Sud, subdistrict 9 (part); and (iii) Health Regions: B (Horizon), subregions B3 (part) and B4 (part); (j) Sandra Clark, St. George, New Brunswick, for: (i) Region M10 (Charlotte): Blacks Harbour, Campobello Island, Grand Manan, Saint Andrews, St. George, and St. Stephen; (ii) School Districts: Anglophone South, subdistricts 1, 2 (part) and 12, Anglophone West, subdistrict 5 (part), Francophone Sud, subdistricts 9 (part) and 10 (part); and (iii) Health Regions: B (Horizon), subregions B3 (part) and B5 (part); (k) Patti Nason, Tracy, New Brunswick, for: (i) Region M11 (Queens-Sunbury-York): Chipman, Fredericton Junction, Gagetown, Hanwell, Harvey, McAdam, Minto, New Maryland, Oromocto, Stanley, and Tracy; (ii) School Districts: Anglophone West, subdistricts 4 (part), 5 (part), 6 (part), 7 (part), 8 (part), 9 (part), 10 (part), 11 (part), 12 and 13, Francophone Sud, subdistrict 10 (part); (l) (iii) Health Regions: B (Horizon), subregions B3 (part), B4 (part), B5 (part) and B6 (part); Megan Harmon, French Lake, New Brunswick, for: (i) Region M12 (Fredericton): Fredericton; (ii) School Districts: Anglophone West, subdistricts 6 (part), 7 (part), 8 (part) and 9 (part), Francophone Sud, subdistrict 10 (part); and (iii) Health Regions: B (Horizon), subregion B6 (part); (m) Lois Demmings, Kilburn, New Brunswick, for: (i) Region M13 (Carleton-Victoria): Aroostook, Bath, Canterbury, Centreville, Florenceville-Bristol, Hartland, Meductic, Millville, Nackawic, Perth-Andover, Plaster Rock, and Woodstock; (ii) School Districts: Anglophone West, subdistricts 1 (part), 2, 3 and 4 (part), Francophone Nord-ouest, subdistricts 7 (part) and 8 (part), Francophone Sud, subdistrict 10 (part); and (iii) Health Regions: B (Horizon), subregion B5 (part); and (n) Francine Mulherin, Grand-Sault, New Brunswick, for: (iii) Régions de la santé : la région de la santé B (Horizon), sous-régions B3 (en partie), B4 (en partie) et B6 (en partie); (i) Richard Thorne, de Hampton (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M09 (Saint John) : Grand Bay-Westfield et Saint John; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone South, sous-districts 2 (en partie), 3 (en partie), 4, 5, 6 et 7 (en partie); le district scolaire Francophone Sud, sousdistrict 9 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé B (Horizon), sous-régions B3 (en partie) et B4 (en partie); j) Sandra Clark, de St. George (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M10 (Charlotte) : Blacks Harbour, Campobello Island, Grand Manan, Saint Andrews, St. George et St. Stephen; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone South, sous-districts 1, 2 (en partie) et 12; le district scolaire Anglophone West, sous-district 5 (en partie); le district scolaire Francophone Sud, sous-districts 9 (en partie) et 10 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé B (Horizon), sous-régions B3 (en partie) et B5 (en partie); k) Patti Nason, de Tracy (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M11 (Queens-Sunbury-York) : Chipman, Fredericton Junction, Gagetown, Hanwell, Harvey, McAdam, Minto, New Maryland, Oromocto, Stanley et Tracy; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone West, sous-districts 4 (en partie), 5 (en partie), 6 (en partie), 7 (en partie), 8 (en partie), 9 (en partie), 10 (en partie), 11 (en partie), 12 et 13; le district scolaire Francophone Sud, sous-district 10 (en partie); (iii) Régions de la santé : la région de la santé B (Horizon), sous-régions B3 (en partie), B4 (en partie), B5 (en partie) et B6 (en partie); l) Megan Harmon, de French Lake (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M12 (Fredericton) : Fredericton; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone West, sous-districts 6 (en partie), 7 (en partie), 8 (en partie) et 9 (en partie); le district scolaire Francophone Sud, sous-district 10 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé B (Horizon), sous-région B6 (en partie); m) Lois Demmings, de Kilburn (Nouveau-Brunswick), pour : (i) la région M13 (Carleton-Victoria) : Aroostook, Bath, Canterbury, Centreville, Florenceville-Bristol, Hartland, Meductic, Millville, Nackawic, Perth-Andover, Plaster Rock et Woodstock; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone West, sous-districts 1 (en partie), 2, 3 et 4 (en partie); le district scolaire Francophone Nord-Ouest, sous-districts 7 (en partie) et 8 (en partie); le district scolaire Francophone Sud, sous-district 10 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé B (Horizon), sous-région B5 (en partie); et n) Francine Mulherin, de Grand-Sault (Nouveau- Brunswick), pour :

The Royal Gazette February 3, 2016 114 Gazette royale 3 février 2016 (i) Region M14 (Madawaska): Baker-Brook, Clair, Drummond, Edmundston, Grand-Sault/Grand Falls, Lac Baker, Rivière-Verte, Saint-André, Sainte-Anne-de- Madawaska, Saint-François de Madawaska, Saint- Léonard, and St. Hilaire; (ii) School Districts: Anglophone West, subdistrict 1 (part), Francophone Nord-ouest, subdistricts 1, 2, 3, 4, 7 (part) and 8 (part); and (iii) Health Regions: A (Vitalité), subregions A3 and A4 (part). Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor (i) la région M14 (Madawaska) : Baker-Brook, Clair, Drummond, Edmundston, Grand-Sault/Grand Falls, Lac Baker, Rivière-Verte, Saint-André, Sainte-Anne-de- Madawaska, Saint-François-de-Madawaska, Saint- Léonard et Saint-Hilaire; (ii) Districts scolaires : le district scolaire Anglophone West, sous-district 1 (en partie); le district scolaire Francophone Nord-Ouest, sous-districts 1, 2, 3, 4, 7 (en partie) et 8 (en partie); et (iii) Régions de la santé : la région de la santé A (Vitalité), sous-régions A3 et A4 (en partie). La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau Business Corporations Act Notice of dissolution of provincial corporations and cancellation of the registration of extra-provincial corporations Notice of dissolution of provincial corporations Take notice that the following provincial corporations have been dissolved as of January 21, 2016, pursuant to paragraph 139(1)(c) of the Business Corporations Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices and/or documents required by the Act. Certificates of Dissolution have been issued dated January 21, 2016. Loi sur les corporations commerciales Avis de dissolution de corporations provinciales et d annulation de l enregistrement des corporations extraprovinciales Avis de dissolution de corporations provinciales Sachez que les corporations provinciales suivantes ont été dissoutes en date du 21 janvier 2016 en vertu de l alinéa 139(1)c) de la Loi sur les corporations commerciales, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du 21 janvier 2016. 056975 056975 N.B. LTD. 502093 502093 N.B. LTD. 611913 611913 N.B. LTD. 611975 611975 N.B. Ltd. 618319 618319 N.B. INC. 637511 637511 Ltd. 637666 637666 N.B. Ltd. 637978 637978 N.B. Inc. 638037 638037 INC. 644049 644049 N.B. LTD. 650242 650242 N.B. LTD. 656987 656987 Ltd. 657092 657092 Inc. 657153 657153 N.B. Inc. 657179 657179 N.B. Inc. 669569 669569 Inc. 669571 669571 Inc. 669615 669615 Inc. 669641 669641 Ltd. 669697 669697 Corporation 669708 669708 Inc. 669733 669733 LTD. 669838 669838 LTD. 669839 669839 LTD. 669890 669890 Ltd. 670029 670029 N.B. Ltd. 670033 670033 Inc. 670082 670082 NEW BRUNSWICK INC. 670150 670150 N.B. INC. 504672 A PLUS AUTO GLASS INC. 657196 AFFUTAGE CHALEUR SHARPENING INC. 504584 ANN S INTERIOR DESIGN LTD. 504480 ARMSTRONG EQUIPMENT RENTALS LTD. 624790 Atlantic Business Interiors () Limited 637626 Atlantic Reef Store inc. 669879 Bayside Brokerage Inc. 504645 BELLE TRAN LTD 669841 BELLEVIE LIGHTING INC. 051756 BOUCHER MAINTENANCE LTD. 644072 Branch Graphic Design Inc. 502078 BROWN AQUACULTURE LTD. 612269 C-MAC PROPERTY SERVICES LTD. 669793 Canada Wide Racking Ltd. 506901 CENTAURUS INSTALLATIONS LTD. 509170 COLEDGE CONSTRUCTION CORPORATION 637873 Coleraine Estates Ltd. 033511 CONSTANTINE S FOREST PRODUCTS LTD. 004200 CONSTRUCTION B.H.M. LIMITEE 669930 CRYPTO TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD. 650662 Currie s Courier Inc 631315 D. LeBlanc Trading Ltée/Ltd. 670092 Decks Plus Ltd. 606358 Destination Baie Chaleur Péninsule Acadienne et Littoral Acadien Inc. 669694 DNH Marketing North America Inc. 637761 DONALD S PAINTING LTD. 509200 DOWNTOWN HOLDINGS INC. 644129 E. Blanchard Homes (2009) Ltd. 053980 ECOLE DE FORMATION DES CONDUCTEURS DE VEHICULES UTILITAIRES DES FRANCOPHONES INC 502249 ELM CITY PAVING LTD. 656805 Entreprise D. Michaud Inc. 502205 EXFOR INC. 006052 F. & R. HOLDINGS LTD. 669664 Forevermore Pet Funeral Products Ltd. 051737 FORSYTHE MURRAY INC. 051885 FRANK S ELECTRIC LTD. 657077 FS Framing Ltd. 657038 FULL TILT DUMPSTER LTD. 657050 Fusion Personal Services Ltd. 644267 GALLA INTERNET ENTERPRISES INC. 657159 Gary Daigle Construction Ltd. 657242 GENCOM SECURITY SYSTEMS & TECHNOLOGIES INC. 663520 Gerald Parsons Trucking Ltd. 643987 GESTION 7272 LTD. 662475 Greener Choice Property Care Inc. 669692 Har Cam T & D Trucking (2013) Inc. 600635 HAYES PROPERTIES INC. 637688 Here 4 You Home Inspections Inc. 630984 HOLDING METRO INC. 669966 ibean Inspired Inc. 631226 Immersion Edutainment Canada Inc. 511837 INN ON THE COVE INC. 657217 J & M Lyons Trucking Ltd. 644029 J F Carpentry Ltd 644352 JAMLIN INC. 506842 JASCO CONSTRUCTION LTD 670072 Jeff Clark Trucking Ltd. 670143 JMRobichaud Professional Services Ltd. 669964 Johnson s Plumbing Ltd. 657164 KCR Crown Exteriors Ltd. 039355 LAJJA INVESTMENTS LTD. 669958 LavaLabs Inc. 669668 LES DÉLICES DE LA MER LTÉE 054067 LES PECHERIES S.L.E. LTEE 669516 Lise Landry c.p. Inc. 669768 LOMATOL INC. 618558 M13 DETAILERS INC. 669617 MAIN MEDICAL LIFTS INC. 514152 Marc Gaudreau Inc. 048990 MARITIME MARTIAL ARTS ACADEMY INC. 669945 Mary Ebra Clothing Inc. 669942 MB Engineering-Consulting Inc. 612136 MCKENNA1 INC. 630994 METRO REALTY INC. 650231 MEXIM International Inc. 618472 Michelle Rioux, CGA PC Inc. 669914 Mission Construction Ltd. 663493 MJK Holdings Inc. 669675 Murad Real Estate & Maintenance Inc.

The Royal Gazette February 3, 2016 115 Gazette royale 3 février 2016 625226 NORTH ATLANTIC HOLDINGS INC. 637539 O Donaghue s Pub & Eatery Inc. 669823 Ocean Pearl Hospitality Inc. 624835 OSTREA AQUACULTURE INC. 611958 Paul Breau Electric Inc. 511663 Pellerin Building Supplies Inc. 663161 PLOMBERIE ET CHAUFFAGE T&T PLUMBING AND HEATING LTÉE/ LTD. 669683 PRECISION MORTGAGE INC. 013362 PRINCE ALBERT REALTY LTD. 669578 R Cormier & Son Trucking Ltd. 644198 REALLY GOOD IT SOLUTIONS INC. 663068 Red Bank Outdoor Adventure Lodge Ltd. 612325 REDC Enterprises Inc. 631386 RENEAU ENERGY INC. 650501 Rothesay Foot & Aesthetic Studio Inc. 650571 RYCO DEVELOPMENTS LTD. 612007 SEAL DISTRIBUTING INC. 669757 Sheepdog Wealth & Property Management Ltd. 618007 SOUTHEAST HOCKEY DEVELOPMENT INC. 650754 Steven Comeau Home Improvement Ltd. 657090 T.H.X. Trucking Ltd. 637838 The Animal Neurology and Ophthalmology Centre Ltd. 059919 TIREX ATLANTIC LTD. 663549 TNTM 1992 CONTRACTING LTD. 669637 TOBIQUE FIRST NATIONS FISHERIES LTD. 670157 Trails End Sports Bar & Grill/Nightclub Ltd. 669987 Trampers Diner Inc. 644089 Trigon Trading Limited 669612 TVG Ventures Inc. 618189 Urquhart Atlantic Homes Ltd. 600823 Valley Machine Holdings Inc. 669589 VM Venture Management Corp. 057013 WARREN DEVELOPMENTS INC. 637506 Wilson Wreath Company Ltd. 618248 Wintergreen Farms Inc. 021413 York Renovations Ltd. Notice of cancellation of registration of extra-provincial corporations Take notice that the registrations of the following extra-provincial corporations have been cancelled as of January 21, 2016, pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Business Corporations Act as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices and/or documents required by the Act: Avis d annulation de l enregistrement des corporations extraprovinciales Sachez que l enregistrement des corporations extraprovinciales suivantes a été annulé en date du 21 janvier 2016 en vertu de l alinéa 201(1)a) de la Loi sur les corporations commerciales, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi : 656917 2052425 Ontario Inc. 670025 6989454 Canada Ltd. 657053 Ascendant Securities Inc. 670126 BATHURST RESOURCES CORP. 618297 CORELAND DEVELOPMENTS INC. 670016 Crossing Mobile Inc. 670090 CROSSWIND CAPITAL CORP. 669604 DHC ADMINISTRATORS INC. 075351 EXCURSIONS NAUTIQUES HARGO INC./HARGO JET BOAT TOUR INC. 624873 FHTM CANADA INC. 650559 Fishing Holdings, LLC 657071 Landry Family Farms, Inc. 076311 MICHEL SEMEGEN HOLDINGS LTD. 019389 MISTER TRANSMISSION (INTERNATIONAL) LIMITED 018982 NORTEL NETWORKS LIMITED/ CORPORATION NORTEL NETWORKS LIMITEE 075348 SNAP-ON CREDIT CANADA LTD/ CRÉDIT SNAP-ON CANADA LTÉE 669686 TIEN ENTERPRISES LTD. 669852 Why Not Lease It Canada ULC Companies Act Loi sur les compagnies Notice of dissolution of provincial companies Take notice that the following provincial companies have been dissolved as of January 21, 2016, pursuant to paragraph 35(1)(c) of the Companies Act, as the said companies have been in default in sending to the Director fees, notices and/or documents required by the Act. Certificates of Dissolution have been issued dated January 21, 2016. Avis de dissolution de compagnies provinciales Soyez avisé que les compagnies provinciales suivantes ont été dissoutes en date du 21 janvier 2016 en vertu de l alinéa 35(1)c) de la Loi sur les compagnies, puisque lesdites compagnies ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du 21 janvier 2016. 002028 BLUE KNIGHTS MOTORCYCLE CLUB, INC. 669532 Fredericton Oromocto Lacrosse Association INC. 009330 KNIGHTS OF COLUMBUS, COUNCIL 937, CHARITIES INC. 025439 LA SOCIÉTÉ AU DÉVELOPPEMENT ET À LA PROMOTION DU HOCKEY MINEUR D ACADIE BATHURST LTÉE 025592 Le Club Communautaire de Hockey Mineur de Cap-Pelé Inc. 010091 LOWER SOUTH TETAGOUCHE COMMUNITY HALL, INC. 663049 Mighty Chi Derby Dames Inc. 023379 MINTO MINOR HOCKEY ASSOCIATION INC. 024928 N.B. Heart Surgery Support Group Inc, Groupe de Soutien Chirurgie Cardiaque N.B. Inc. 023990 PASSAMAQUODDY CHILDREN S CENTRE INC. 025273 SAINT JOHN APARTMENT OWNERS ASSOCIATION LTD. 611903 THE NEW BRUNSWICK KART CLUB INC. 024177 THE SCOUDOUC RIVER CANOE CLUB INC. 016451 THE TRUSTEES OF THE SAINT JOHN YOUNG MEN S CHRISTIAN ASSOCIATION

The Royal Gazette February 3, 2016 116 Gazette royale 3 février 2016 Partnerships and Business Names Registration Act TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Partnerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5, the Registrar under the said Act has cancelled, effective January 21, 2016, the registration of the certificates of partnership of the firms set forth in Schedule A annexed hereto and the certificates of business names of the businesses set forth in Schedule B annexed hereto by reason of the fact the said firms and businesses have failed to register certificates of renewal in accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7), as the case may be applicable, of the said Act. Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a annulé, le 21 janvier 2016, en vertu de ladite loi, l enregistrement des certificats de sociétés en nom collectif indiqués à l Annexe «A» ci-jointe et des certificats d appellations commerciales des commerces indiqués à l annexe «B» ci-jointe en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à l alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon le cas. Schedule A / Annexe «A» Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif 649336 Bladez 649348 C & S Allen Business Consulting 309751 D & J TAXI SERVICE 643244 Daigle et Associé(e)s 610810 JAMES BROOK FARM 649060 Restigouche Cinemas 649237 She Roars Music 649284 The Olive Branch Restaurant 2010 Schedule B / Annexe «B» Certificates of Business names / Certificats d appellations commerciales 630411 (GMR) Good Measure Renovations 649156 A Second Look Editing 649257 AAA Delivery 649368 ALMA CLEANING SERVICES 649070 Alu Fox 649054 Apple n Spice Soap Crafting 649461 ATLANTIC GEOTHERMAL SOLUTIONS 319332 ATLANTIC LABELS 649275 AU JOLI CADEAU 600135 AUTOINDULGENCE 611183 B.N.G. Construction 649355 Babette Hayward Sirens 649104 BATH SOLUTIONS OF MONCTON 649147 Best for Pets Pet Supplies 648751 Blossoms Fresh Fruit Arrangements 649126 BONITA CONVENIENCE 648980 Boudreau Service Station 649043 Braid Media Services 649109 BRUCE A. HOLLETT & ASSOCIATES 649073 CAFFE IN VENDING 649491 Cakeopolis 649420 CAMMO CREW 649182 Carbuyershelp Reg d 616824 CENTRE DE PSYCHOLOGY MONCTON PSYCHOLOGY CENTER 649216 chaussures pashoenate shoes 649322 CONSTRUCTION ARC-EN-CIEL 649414 CORMAX Internet Marketing Group 649490 Cosy Comfort Gas Heating 649499 D. Dykens Construction 649062 D.S.M. Agencies 649100 Direct Health Solutions 649560 DON GALLON S AUTO SERVICE 649151 Doucet Small Engine Repair 649153 Droits Linguistiques Francophone SOS 649306 DUAL QUANT INFORMATICS 649405 DV Counselling & Consultation 346219 Dynamic Solutions 332676 ECOLE DE COIFFURE DE LA PENINSULE 649370 EJA S Construction 649371 EJA S SALON 649500 Emelie Hubert & Associates 648084 Fawcett s All In One Services 649223 FILLIER S ODD JOBS 649264 Foot Notes Reflexology 649093 Forever as One Photography and Findings 616680 Fredericton Pool Club 648836 Friendly s Convenience Store 649309 G. HANSEN AUTO 649522 Gagetown Camping 649041 Gift Giver s Haven 649132 GMR Video & Editing 649473 GOGIRO ATLANTIC CANADA 649290 Gorent.ca 649068 Green Leaf Massage Therapy 649225 Hair Secrets by Lorraine 649467 IMAGINATION UNLIMITED BY CAE 649158 INTERCON 649160 INTERCON SECURITY 649497 J S DENEIGEMENT ET TONTE DE PELOUSE 348596 J.A. (TONY) CHEVALIER CONSULTING 648994 J.D.R. SPORT 647661 Jeux franco-canadiens de la communication, Moncton 2010 649470 Jim LeBlanc Housing 649407 K.O. Coupons 649080 Kick Beef Jerky 649047 KIRSCHER TRANSPORT 649549 LaPierre Inventions 649444 Linda s Tidy Spaces 649438 Little Hippo Baby Boutique 649200 Long Creek Timber 649079 LORBER PUBLICATIONS 649382 M Squared Design Build 649455 Maritime Pro Sealing 649231 Maritimes JUG 649537 Matt Music 649456 Mel s Waggin Tail Inn 649228 Melabrand Enterprises 649238 Melanie Lutes Registered Massage Therapy 611018 Mike White Computers & Consulting 647999 Moloney Electric - Atlantic Service & Training Division 649199 MountainWay Sports & Awards 649053 MP Bergeron Créations 649310 MSH RENOVATIONS 649567 MURRAY AND ASSOCIATES INTERNATIONAL EDUCATION CONSULTING 616529 NexGen Electric 649166 Nor East Renovations 649502 P. St-onge & Associates 648544 PAM S Restaurant 649307 PAWS HERE DOGGY DAY CARE 649224 Pine Glen Auto Collision 346001 Playcenter Child Care Services 610791 POOL IS COOL 649359 PRINCE STREET PROPERTY 649142 Prince William Food and Variety 610993 Pro - Radiateur 649105 Recorded Treasures Photography 649271 RELIABLE DRYWALL 649476 RÉNOVATION RESTIGOUCHE RENOVATIONS 649579 Résidence Lanteigne Enrg. 649115 Restigouche Handyman Services 649063 RIVER MEADOW STABLES 649428 RJC ACCOUNTING SERVICES 649436 Rock and Load Web Design 649542 SALMON RIDGE DEVELOPMENTS 616621 SARA DUNTON DESIGN 649139 Silverlining Home Design 649342 SNC-Lavalin Environment, Division of SNC-Lavalin Inc. 649343 SNC-Lavalin Environnement, Division de SNC-Lavalin Inc. 649391 SNC-Lavalin, Division Environnement 649392 SNC-Lavalin, Environment Division

The Royal Gazette February 3, 2016 117 Gazette royale 3 février 2016 649133 Spitfire Weld and Fabrication 649196 Spookie s Smoke Shack 649323 Step by Step Daycare 649404 Stitch to Fit Custom Home Designs 649148 Strykers Construction 649294 StudioSarah 649279 The Extraordinary Assistant 649337 The Gaming and Animation Institute of Fredericton 649401 The Home & Vacuum Shop 2010 649107 The Quebec Chronicle - Telegraph 649167 The Reading Cat 649593 Thoughts, Ideas & Designs 649136 Tippie Toes DayCare 649281 Treats & Sweets Vending 649128 True Gaming 649191 Twenty-One x Twelve Wellness Challenge 649076 Underground Tunes 616731 WHITE BIRCH OF ALBERT COUNTY 649575 WICKED GOOD TREATS 647708 WILBUR & WILBUR 649276 Wise Living Financial 649101 Work Able Centres 312478 WULASTOOK REAL ESTATE 649267 www.maritimeoverstock.com 649135 ZERON SAGHDEJIAN CONSULTING 649570 Zulueta Acosta Cleaning Services Business Corporations Act PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of incorporation has been issued to: Loi sur les corporations commerciales SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour 686231 N.B. Inc. Jewetts Mills 686231 2015 12 28 Hood Farm Inc. Lower Queensbury 686244 2016 01 07 Autumn Lee Retirement Home Sackville Inc. Sackville 686557 2015 12 17 AtlantiCare Health Providers Inc./ AtlantiCare Services Santé Inc. Dieppe 686767 2016 01 07 MATHIEU PICOTIN CONSTRUCTION LTÉE Saint-Jacques 686850 2016 01 06 Mamacha Electrical Inc. Oromocto 686855 2016 01 06 Green Earth Properties Ltd. Nasonworth 686864 2016 01 07 Acme Dirt Co. Ltd. Hanwell 686866 2016 01 07 MH ENTERPRISES LTD. Nashwaak Bridge 686868 2016 01 07 PERIWINKLE FARM INC. Bayside 686869 2016 01 07 SCHRICK S PLUMBING LTD. Hampton 686870 2016 01 07 PALLADIUM REAL ESTATE AND PROPERTY MANAGEMENT LTD. Rothesay 686871 2016 01 07 Nicholas Smith Enterprises Limited Shediac 686880 2016 01 07 Wilson s Fencing Inc. Pine Glen 686883 2016 01 08 686884 N.B. Inc. Riverview 686884 2016 01 08 686885 N.B. Inc. Moncton 686885 2016 01 08 VistaView Holdings Inc. Gagetown 686887 2016 01 08 Conley Fisheries Ltd. Cummings Cove 686889 2016 01 08 Yesteryear Antiques, Mantiques and Thrift Shop Inc. Lake George 686890 2016 01 08 Loyalist Luxury Goods Incorporated Berry Mills 686891 2016 01 08 686893 N.B. Inc. Waasis 686893 2016 01 08 GARMEN HOLDINGS INC. Douglas 686895 2016 01 08 PHAZE III Pub Inc. Moncton 686898 2016 01 08 686899 N.B. Inc. Quispamsis 686899 2016 01 08

The Royal Gazette February 3, 2016 118 Gazette royale 3 février 2016 686901 N.B. Inc. Saint John 686901 2016 01 11 CURO International Ltd. Saint John 686902 2016 01 11 686912 N.B. INC. New Maryland 686912 2016 01 11 JEFFERSON IRON CANADA CORP. Fredericton 686916 2016 01 11 686917 Inc. Moncton 686917 2016 01 11 686919 N.B. Inc. Shediac 686919 2016 01 11 KDJ Distribution Inc. Shippagan 686927 2016 01 12 PÊCHERIES LE BARBEAU LTÉE Petite-Rivière-de-L Île 686930 2016 01 12 PECHERIES SERGE DUGUAY INC. Shippagan 686931 2016 01 12 SOCIÉTÉ DE GESTION LÉANDRE WARD LTÉE Petite-Rivière-de-L Île 686933 2016 01 12 Paul Downey Financial Inc. Rothesay 686934 2016 01 12 686935 LTD. Norton 686935 2016 01 12 Pêcheries BEPW Inc. Lamèque 686936 2016 01 12 Onriser Technology Inc. Rothesay 686937 2016 01 12 686938 New Brunswick Inc. Dieppe 686938 2016 01 12 A P & P ENTERPRISES LTD. Saint John 686943 2016 01 12 Shroogal Inc. Fredericton 686944 2016 01 12 686949 N.B. Ltd. Moncton 686949 2016 01 12 686950 Inc. Hampton 686950 2016 01 12 686952 N.B. Inc. Moncton 686952 2016 01 12 PÊCHERIES BOUM LTÉE Pigeon Hill 686953 2016 01 12 Mike Masters Enterprises Inc. Bathurst 686957 2016 01 13 PECHERIES CHRISTIAN H. LTEE Cap-Bateau 686958 2016 01 13 Pure Body Laser Clinic Inc. Dutch Valley 686959 2016 01 13 PECHERIES LE P TIT COTIER LTEE Miscou 686966 2016 01 13 GESTION LE P TIT COTIER LTEE Miscou 686968 2016 01 13 ValleyView Living Inc. Nashwaak Bridge 686969 2016 01 13 Dr. Suma S. Satya Prof. Corp. Saint John 686972 2016 01 13 TG CONSTRUCTION SOLUTIONS LTD. Dieppe 686973 2016 01 13 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of continuance has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de prorogation a été émis à : Previous Reference Jurisdiction Number Date Registered Office Compétence Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour 686477 INC. Saint John Colombie-Britannique / British Columbia 686477 2015 12 31

The Royal Gazette February 3, 2016 119 Gazette royale 3 février 2016 DRAMIS NETWORK CABLING (N.S.) LIMITED Moncton Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 686713 2015 12 29 MTORRES ENERGY CANADA CORP. Moncton Ontario 686725 2015 12 29 OSII Canada Inc. Saint John Nouvelle-Écosse / 686742 2015 12 31 Nova Scotia PNE-BCP Wind Inc. Saint John Canada 686747 2015 12 29 J.H. Horton Insurance Agency Limited Saint John Nouvelle-Écosse / Nova Scotia Better Service Insurance Ltd. Saint John Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 686772 2015 12 31 686773 2015 12 31 SILANIS TECHNOLOGY INC. TECHNOLOGIE SILANIS INC. Saint John Canada 686776 2015 12 31 ILLY ESPRESSO CANADA INC. Fredericton Ontario 686786 2015 12 31 A.C. TECHNAV SUPPORT INC. Cambridge-Narrows Québec / Quebec 686825 2016 01 01 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification a été émis à : Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour Dr. Paul D. Keyes Professional Corporation 507310 2016 01 08 056880 N.-B. Ltée 631010 2016 01 12 Foster Fisheries Inc. 663206 2016 01 12 Benchmark Fabricators Inc. 682579 2016 01 11 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment which includes a change in name has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification contenant un changement de raison sociale a été émis à : Date Previous name Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour DR. ALFONSO GOMEZ-JIMENEZ PROFESSIONAL CORPORATION DR. ALFONSO GOMEZ-JIMINEZ PROFESSIONAL CORPORATION 503347 2016 01 11 DEP INTERNATIONAL INC. 664954 N.-B. INC. 664954 2016 01 08 COWI North America Ltd. BUCKLAND & TAYLOR LTD. 666351 2016 01 01 Northern Group of Companies Inc. Leprechaun Management Inc. 678441 2016 01 11 Services Financiers Goguen Champlain Financial Services Inc. 636337 N.-B. LTEE 686810 2016 01 03

The Royal Gazette February 3, 2016 120 Gazette royale 3 février 2016 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amalgamation has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de fusion a été émis à : Reference Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour P. GREER ENTERPRISES LTD. P. GREER ENTERPRISES LTD. P. Greer Investments Ltd. Plaster Rock 683599 2016 01 11 JOCYA ENTERPRISES LTD. SANDI-CO INC. Ferme Bancourt Ltée Justin Time Landscaping Ltd. JOCYA ENTERPRISES LTD. SAND HOLDINGS LTD. SANDI-CO INC. FERME DESCHENES ET LABRIE INC. FERME BANCOURT LTEE Cap-Pelé 684817 2016 01 01 Fredericton 686689 2016 01 01 Saint-Quentin 686706 2016 01 01 515732 N.B. INC. 515732 N.B. INC. 629237 N.B. Inc. Dieppe 686712 2016 01 01 DRAMIS COMMUNICATIONS SOLUTIONS LTD. Dramis Network Cabling (2009) Ltd. DRAMIS NETWORK CABLING (N.S.) LIMITED Moncton 686714 2016 01 01 665811 N.B. Ltd. JK Management Corp. 665811 N.B. Ltd. Riverview 686718 2016 01 01 Hatchard Engineering Ltd. Jardine Transport Ltd./ Transport Jardine Ltee Mills Aquaculture Inc. CRA Canadian Holdings Inc. AUDIO VISUAL SERVICES (CANADA) CORPORATION 512744 N.B. Ltd. Hatchard Engineering Ltd. Jardine Transport Ltd./ Transport Jardine Ltee 681454 N.B. Ltd. Mills Aquaculture Inc. OSII Canada Inc. 051108 N.B. INC. 051109 N.B. INC. AUDIO VISUAL SERVICES (CANADA) CORPORATION 686477 INC. Beardsley 686720 2016 01 01 Saint John 686741 2016 01 01 Saint John 686743 2016 01 01 Saint John 686746 2016 01 01 Saint John 686749 2016 01 01 600102 N.B. LTD. 600102 N.B. LTD. CHARLES P. CURRAN TRUCKING LTD. Johnson Settlement 686751 2016 01 01 Admiral Glass Ltd. Réclamation Marsh Adjustment Limited E.C. LeDrew Services P.C. Incorporated Nova Insurance Ltd. D.F.S. INC. ADMIRAL AUTO GLASS LTD. ADMIRAL GLASS LTD. EAST COAST CLAIM SERVICES INC. BRUNSWICK CLAIMS SERVICES INC. E.C. LeDrew Services P.C. Incorporated E.C. LeDrew P.C. Incorporated Nova Insurance Ltd. J.H. Horton Insurance Agency Limited Better Service Insurance Ltd. D.F.S. INC. 679685 N.B. Inc. Fredericton 686762 2016 01 01 Moncton 686764 2016 01 01 Moncton 686771 2016 01 01 Saint John 686774 2016 01 01 Saint John 686775 2016 01 01

The Royal Gazette February 3, 2016 121 Gazette royale 3 février 2016 685102 N.B. Inc. 685102 N.B. Inc. SILANIS TECHNOLOGY INC. TECHNOLOGIE SILANIS INC. Saint John 686777 2016 01 01 Riley Home Care Inc. RILEY HOME CARE INC. 513029 N.B. INC. Grand Bay-Westfield 686778 2016 01 01 Covered Bridge Farms Ltd. Valley Equipment Limited BIRD HOLDINGS LTD. COVERED BRIDGE FARMS LTD. RIVERVIEW STORAGE INC. COOKS REALTY LTD. VALLEY EQUIPMENT LIMITED BIRD HOLDINGS LTD. BIRD LANDS LIMITED Hartland 686782 2016 01 01 Hartland 686783 2016 01 01 Fredericton 686784 2016 01 01 661370 N.B. Inc. 609173 N.B. LTD. 661352 N.B. LTD. 661369 N.B. Inc. 661370 N.B. Inc. 636337 N.-B. LTEE Services financiers Goguen Champlain Financial Services Inc. 636337 N.-B. Ltée Rusagonis 686785 2016 01 01 Moncton 686810 2016 01 03 Dr. Jean-François Guité Dr. Jean-François Guité Corporation Professionnelle Inc. Direct Air Charter Services Inc. Little Shemogue 686865 2016 01 01 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of dissolution has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de dissolution a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour PARKSIDE HOLDINGS INC. Fredericton 010119 2015 12 29 R. & R. GALLANT CONSTRUCTION INC. Saint-Ignace 058151 2015 12 29 M & M FIRE PROTECTION D INCENDIE INC. Campbellton 501459 2016 01 08 PARAGROUP SALES BROKERAGE INC. Dieppe 503289 2016 01 07 HOLLICO INC. Nasonworth 512700 2016 01 06 ARCOR CANADA INC. Saint John 514387 2015 12 23 Armstrong Security Alarm Monitoring Ltd. Coal Creek 601823 2015 12 23 Cinemark Theatres Canada, Inc. Saint John 608664 2015 12 31 Wayne s Jewellery & Gifts Inc. Campbellton 615047 2015 12 29 M.T. Doiron P.C. Inc. Dieppe 616068 2015 12 23 Steluc Enterprises Inc. Miramichi 619090 2015 12 31 620076 INC. Robertville 620076 2016 01 08 626087 Limited Fredericton 626087 2015 12 30 Damaris Holdings Inc. Fredericton 633563 2015 12 31 Maulihoggin Inc. Woodstock 633943 2015 12 31 Assurance Nathalie Bowser Insurance Inc. Edmundston 635228 2015 12 29

The Royal Gazette February 3, 2016 122 Gazette royale 3 février 2016 The Bluebird Cafe Inc. Moncton 643296 2015 12 30 Kork Management Inc. Woodstock 644296 2015 12 31 A.L. BIBBY TRUCKING LTD. Lower Coverdale 645064 2016 01 05 Lax Veida Limited Saint John 645297 2015 12 31 NORTHWEST SHIPPING & RECEIVING INC. Grand-Sault / Grand Falls 645907 2015 12 31 Gym-Mobile Recreation Products, Inc. Fredericton 646692 2015 12 31 CALEDONIAN INTERNATIONAL LIMITED Saint John 648320 2015 12 29 KOUROS INTERNATIONAL LIMITED Saint John 648321 2015 12 29 649454 N.B. Inc. Saint John 649454 2015 12 31 Yorkshire Wind Park GP Inc. Saint John 653792 2015 12 29 Elizabethtown Solar Park 1 GP Inc. Saint John 654025 2015 12 29 Prince Edward Solar Park 1 GP INC. Saint John 655836 2015 12 29 Pendleton Solar 1 GP Inc. Saint John 657729 2015 12 29 TE Solar Woodstock GP Inc. Saint John 659619 2015 12 29 661914 N.B. Inc. Fredericton 661914 2015 12 31 Dr. John A. Grant Professional Corporation Saint John 663515 2015 12 31 Maritime Bar Supply Inc. Moncton 663799 2016 01 06 STEPHANE CORMIER & FILS INC. Seaside 664747 2015 12 30 YOUR PARTY DELIVERED.CA INC. Moncton 669286 2015 12 31 HIGGINS CONVENTIONAL LOGGING LTD. Linton Corner 671286 2015 12 23 Tammy Mount Inc. Dieppe 671856 2015 12 31 674109 N.B. Ltd. Saint John 674109 2015 12 31 Dolpro Technologies Inc. Quispamsis 675206 2015 12 23 679587 Ltd. Saint John 679587 2015 12 31 685702 N.B. Limited Saint John 685702 2015 12 31 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of revival has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de reconstitution a été émis à : Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour ARJ NUCLEAR LTD. 515868 2015 12 11 Zonare Medical Systems Canada, Ltd. 630672 2016 01 08

The Royal Gazette February 3, 2016 123 Gazette royale 3 février 2016 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation has been issued to: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Reference Number Date Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour 9480161 Canada Inc. Canada Philippe Boulay Dieppe Modern Advisor Canada Inc. Canada Stewart McKelvey Corporate Services () Inc. Saint John IBI Group Architects (Canada) Inc. Canada Stewart McKelvey Corporate Services () Inc. Saint John 685839 2016 01 11 686670 2015 12 23 686711 2015 12 29 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, the Director has made a decision to cancel the registration of the following extra-provincial corporations: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, le Directeur a décidé d annuler l enregistrement des corporations extraprovinciales suivantes : Proposed Cancellation Reference Notice Date Date / Date de Number Date de l avis l annulation projetée Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour LES PROMENADES CYR INC. Québec / Quebec Ronald J. LeBlanc 071098 2016 01 11 2016 04 09 Irving Oil Transportation Company LLC Delaware Chris Borden 077217 2016 01 11 2016 04 09 Eagle Energy Inc. Alberta Stewart McKelvey Corporate Services () Inc. 654854 2016 01 11 2016 04 09 Travel Counsellors (Canada) Ltd. Canada Alan Schelew 661089 2016 01 11 2016 04 09 MPÉCO Construction Inc. Québec / Quebec Willard M. Jenkins 667404 2016 01 11 2016 04 09 Lakeview Hotel Investment Corp. Canada Stewart McKelvey Corporate Services () Inc. 667787 2016 01 11 2016 04 09 Barkhof Holsteins Inc. Alberta George B. Smith 669920 2016 01 11 2016 04 09 Grimmway Enterprises, Inc. Californie / California Deborah M. Power 678286 2016 01 11 2016 04 09 INVIVO SUPPLY, ULC Colombie Britannique / British Columbia Daniel W. McCormack 679188 2016 01 11 2016 04 09 INFOR FINANCIAL INC. Ontario Stewart McKelvey Corporate Services () Inc. 684068 2016 01 11 2016 04 09

The Royal Gazette February 3, 2016 124 Gazette royale 3 février 2016 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of amalgamated corporation has been issued to the following extra-provincial corporations: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d enregistrement d une corporation extraprovinciale issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Reference Agent and Address Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour AVENIR CONSOLIDATED CORPORATION Avenir CC Finance Inc. Stewart McKelvey Corporate Services () Inc. Saint John 686708 2015 12 29 Euro Pacific Canada Inc. Pope & Company Limited Euro Pacific Canada Inc. Stewart McKelvey Corporate Services () Inc. Saint John 686710 2015 12 29 Companies Act PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, letters patent have been granted to: Loi sur les compagnies SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes ont été émises à : Reference Number Date Head Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Siège social référence année mois jour Comité de mieux-être de Memramcook Wellness Committee Inc./ Comité J MEM Inc. Memramcook 685698 2015 12 29 St. Martins Summer Theatre Inc. St. Martins 686724 2016 01 02 FUNDY SEASIDE BAPTIST CHURCH INC. Dipper Harbour 686732 2015 12 29 NEW BRUNSWICK MEDICAL EDUCATION FOUNDATION INC. Saint John 686781 2015 12 31 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, the surrender of charter has been accepted and the company has been dissolved: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les compagnies, l abandon de la charte des corporations suivantes a été accepté, et que celles-ci sont dissoutes : Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de réference année mois jour Changes Non-Profit Enterprises Inc. 634418 2016 01 08

The Royal Gazette February 3, 2016 125 Gazette royale 3 février 2016 Partnerships and Business Names Registration Act PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of business name has been registered: Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour THE EXPRESS CONVENIENCE 685182 INC. Oromocto 686356 2016 01 11 Alward s Plumbing and Heating Benjamin Alward Riceville 686663 2016 01 11 Kruger Products Kruger Products L.P. Saint John 686715 2015 12 29 Produits Kruger Kruger Products L.P. Saint John 686716 2015 12 29 SPLIT HEAT PUMPS CANADA Reginald Gallant Moncton 686730 2016 01 01 The Moncton Spray Shop 676333 INC. Moncton 686733 2016 01 07 BACHMANN WOOD & ASSOCIATES 628226 N.B. Inc. Riverview 686754 2015 12 30 Acme Pest Control Cliffton Donally Saint John 686820 2016 01 07 Billings Tree Service Jacob Terrance Billings Moncton 686838 2016 01 05 ON THE MEND CANINE CONSULTANTS Pauline Cormier Haute-Aboujagane 686848 2016 01 06 The Apple Tree Market Julie Baglole Keenan Gagetown 686854 2016 01 06 FALAFEL DELIGHT Shokooh Mostafaie Fredericton 686856 2016 01 06 Algorithmic Bias Software Hugues Landry Grand-Barachois 686857 2016 01 06 Sophia s Nails Nga Nguyen Miramichi 686860 2016 01 07 TODD MOORE MASONRY & CHIMNEY REPAIR Todd Moore Richibucto Road 686861 2016 01 07 SHANKS REALTY Esther Shanks Fredericton 686867 2016 01 07 Fundyview Specialty Drafting Design Hector Sonier Alma 686879 2016 01 07 Second Wind Music Centre Peter McLaughlin Florenceville-Bristol 686881 2016 01 07 The Drone News Jimmy Houssen Moncton 686882 2016 01 08 Build It Now Carpentry Christopher Maxon Fredericton 686888 2016 01 08 Merlagator Services Merle Crandall Colpitts Settlement 686892 2016 01 08 Lakeville Business Consulting Carol Rickard Lakeville Corner 686913 2016 01 11 James Clark s Woodworks James Clark Riverbank Comté de Carleton County Impact inspection services Yann St-Pierre DSL de Drummond / LSD of Drummond 686914 2016 01 11 686924 2016 01 11 Polar Bear Snow Removal Tanya Nolti Moncton 686925 2016 01 11 Wade Settle Connections Wade Settle Dorchester 686926 2016 01 11

The Royal Gazette February 3, 2016 126 Gazette royale 3 février 2016 CHESAPEAKE CONTRACTING Jason Owens Haineytown 686942 2016 01 12 Q Strategic Consulting Peter Corbyn Hanwell 686954 2016 01 12 Easy Fashion Adaptive Clothing Cynthia Mae Brown Fredericton 686955 2016 01 13 C2 Craft Policy Consulting Christopher Jones Fredericton 686970 2016 01 13 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business name has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour NEIGHBOURHOOD RECYCLING RAYAN INVESTMENTS LTD. Moncton 325098 2016 01 12 VSL CANADA VSL CANADA LTD./VSL CANADA LTEE Saint John 337404 2016 01 13 HARRIS PT Harris Steel ULC Saint John 338751 2016 01 13 CHANTAL WITZELL COMPTABILITÉ RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Anne Chantal Witzell Tilley Road 348580 2016 01 12 RIOCAN HOLDINGS INC. Saint John 350355 2016 01 11 Cut Loose Hair Salon Shelly Smythe St. Stephen 622184 2016 01 12 EASTSIDE AUTO & RV EASTSIDE AUTO SALES LTD. Bathurst 622400 2016 01 12 Shacklo Media Shane Long Fredericton 622930 2016 01 13 BAYSIDE IRON Frank James Bayside 623591 2016 01 12 R B PAINTERS Roy Brooks Hanwell 624459 2016 01 07 Oldcastle BuildingEnvelope Canada St. Andrews Home Hardware Oldcastle BuildingEnvelope Canada Inc. ST. ANDREWS HARDWARE LTD. Saint John 652591 2016 01 08 Saint Andrews 654480 2016 01 13 Bricor Communications Brian Cormier Moncton 654734 2016 01 13 Celebrations by Sarah Sarah Redmond Oak Bay 655159 2016 01 08 WALLY S TRAILER PARK 629061 N.B. Ltd. Cambridge Narrows 655983 2016 01 11 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l activité ou de cessation d emploi de l appellation commerciale a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour SERVICES FINANCIERS CANADIAN TIRE Saint John 353334 2016 01 08 CANADIAN TIRE FINANCIAL SERVICES Saint John 353335 2016 01 08

The Royal Gazette February 3, 2016 127 Gazette royale 3 février 2016 CTFS Saint John 353336 2016 01 08 Southwest Security Saint John 656013 2016 01 12 Lawrence Landscaping Saint John 670151 2016 01 11 WILSON S FENCING Pine Glen 681706 2016 01 08 CAMPBELL S PLUMBING & HEATING Moncton 686439 2016 01 08 Q Strategic Agency Hanwell 686613 2016 01 13 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business Reference or Agent Number Date Adresse du commerce Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour Debit Paper Direct Christopher James Calvin Ploss Natalie Delia Ploss Riverview 686037 2016 01 12 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Reference Adresse du Number Date commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour GE CANADA ASSET FINANCING/ FINANCEMENT D ACTIFS GE CANADA GE Capital Canada Finance Inc./ Financement GE Capital Canada Inc. GE Canada Asset Financing Company Saint John 622943 2015 12 30 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de dissolution de société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour Split Heat Pumps Canada Moncton 637080 2015 12 31 Hood Farm Lower Queensbury 671625 2016 01 07

The Royal Gazette February 3, 2016 128 Gazette royale 3 février 2016 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of membership of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d associé d une société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Date Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour GE CANADA ASSET FINANCING/ FINANCEMENT D ACTIFS GE CANADA General Electric Capital Canada/ Capital Générale Électrique du Canada GE Capital Canada Finance Inc./ Financement GE Capital Canada Inc 622943 2015 12 30 Notices Avis ESTATE NOTICE By order of 11 December 2015, the Probate Office of the City of Schaffhausen has decreed that in accordance with Article 555 Section 1 of the Swiss Civil Code (ZGB), in conjunction with Article 76 of the canton s Introductory Act to the Swiss Civil Code (EGzZGB), beneficiaries of the estate of John Geoffrey Lloyd Binoth are to be publicly invited to claim their inheritance. The Deceased Estates Notice is being published in the official journal of the Canton of Schaffhausen and in The Royal Gazette of the Province of New Brunswick (CAN). The legal heirs on the mother s side of John Geoffrey Lloyd Binoth, born on 12 April 1952, of Basel BS, single, residing at Neustadt 10, 8200 Schaffhausen and who died on 15 June 2015 in Schaffhausen are hereby invited to make themselves known to the Erbschaftsbehörde der Stadt Schaffhausen (Probate Office of the City of Schaffhausen), Vorstadt 43, 8201 Schaffhausen, Switzerland presenting evidence of their right to inheritance. The period within which to come forward for inheritance is one year from the publication of the Estate Notice. Schaffhausen, 7 January 2016 PROBATE OFFICE CITY OF SCHAFFHAUSEN APPEL AUX HÉRITIERS Par décision du 11 décembre 2015 l Office des successions de la ville de Schaffhouse a ordonné que, conformément à l art. 555 alinéa 1 du Code civil, en liaison avec l art. 76 de la Loi cantonale d introduction du code civil (ZGB) les ayants-droits à la succession de John Geoffrey Lloyd Binoth doivent être invités officiellement à se manifester pour la dévolution successorale. La sommation aux ayants-droit est lancée dans le Journal officiel du canton de Schaffhouse ainsi que dans la Gazette royale de la province du Nouveau-Brunswick (CAN). Par la présente, les héritiers légaux, du côté maternel, de John Geoffrey Lloyd Binoth, né le 12 avril 1952, de Bâle, Bâle-Ville, célibataire, anciennement domicilié à Neustadt 10, 8200 Schaffhouse décédé le 15 juin 2015 à Schaffhouse sont invités à se manifester auprès de l Office des successions de la ville de Schaffhouse, Vorstadt 43, 8201 Schaffhouse, Suisse en apportant, dans le cadre de l appel aux héritiers, la preuve de leur droit à succession. Dans le cadre de l appel aux héritiers, le délai de notification est d un an. Schaffhouse, le 7 janvier 2016 OFFICE DES SUCCESSIONS DE LA VILLE DE SCHAFFHOUSE