The Royal Gazette New Brunswick Gazette royale Nouveau-Brunswick ISSN 1714-9428 Vol. 171 Wednesday, July 24, 2013 / Le mercredi 24 juillet 2013 1031 Notice to Readers Avis aux lecteurs The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. Business Corporations Act Act, a certificate of incorporation has been issued to: Loi sur les corporations commerciales un certificat de constitution en corporation a été émis à : Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour Kevin A Morrison Transport Ltd. Deerville 671126 2013 07 01 BHK Enterprise Ltd. Upper Brighton 671165 2013 07 01 671175 NB Inc. Miramichi 671175 2013 06 27 MORRISON APARTMENTS INC. Beresford 671176 2013 06 27 LIFETIME 360 HOME ACCESSIBILITY SOLUTIONS INC. Moncton 671179 2013 06 28
The Royal Gazette July 24, 2013 1032 Gazette royale 24 juillet 2013 ROB FLYNN CONTRACTING LTD. 671182 2013 06 28 Sonya Fraser Professional Corporation 671185 2013 06 28 WorkSafeNB Investments Limited 671190 2013 06 28 G-JET Enterprises Inc. Sainte-Louise 671194 2013 06 28 IBC Impact Business Communication Inc. Sussex 671195 2013 06 28 Richard Cormier Holdings Ltd. Cap-Pelé 671203 2013 07 01 Zumac Construction Inc. Moncton 671210 2013 07 02 HAP-999 Transmutation Inc. Bouctouche 671211 2013 07 02 Always Trucking Inc. 671213 2013 07 02 Adara Developments Inc. 671214 2013 07 02 671216 NB INC. Tracadie-Sheila 671216 2013 07 02 Minky IT Service Ltd. 671218 2013 07 02 671219 N.-B. Ltée Saint-André 671219 2013 07 02 On The Trail Adventures Ltd. Windsor 671220 2013 07 02 Oshkosh Defense Canada Incorporated 671224 2013 07 02 Thinking Management Inc. 671226 2013 07 02 DDT Logging Ltd. Lansdowne 671227 2013 07 02 AIRFLO TECHNOLOGIES INC. Bass River 671228 2013 07 02 High Voltage Electric Inc. 671229 2013 07 02 Diamond Complex Estates Inc. Moncton 671230 2013 07 02 KILLAM S PIZZERIA AND TAKE-OUT LTD. Petitcodiac 671231 2013 07 02 671234 N.B. Inc. Shediac Cape 671234 2013 07 03 Florist North America Inc. 671239 2013 07 03 FREDERICTON ZB IMMIGRANT INVESTING ENTITY LTD. CACN OVERSEAS IMMIGRATION AND INVESTMENT SERVICES CO. LTD. 671243 2013 07 03 671244 2013 07 03 Act, a certificate of amendment has been issued to: un certificat de modification a été émis à : Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour ADRICE CORMIER LTD. - ADRICE CORMIER LTEE. 004300 2013 07 01 DOBBELSTEYN SIGNS LTD. 034609 2013 06 28 WALLACE EQUIPMENT LTD. 609943 2013 07 01 Wright Express Canada, Ltd. 629540 2013 06 28 Dynamic Transport Inc. 637848 2013 06 28
The Royal Gazette July 24, 2013 1033 Gazette royale 24 juillet 2013 643809 N.B. INC. 643809 2013 07 03 650197 N.B. INC. 650197 2013 07 02 PedersenMedia Inc. 651131 2013 06 28 CDC Robichaud Residences Inc. 651527 2013 07 02 Berkeley Research Group (Canada) Limited 663984 2013 07 03 664324 N.B. INC. 664324 2013 06 28 Dr. Lisa McKnight Professional Corporation 664926 2013 06 28 Act, a certificate of amendment which includes a change in name has been issued to: un certificat de modification contenant un changement de raison sociale a été émis à : Previous name Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour 609943 N.B. Ltd. WALLACE EQUIPMENT LTD. 609943 2013 07 01 WEX Canada Ltd. Wright Express Canada, Ltd. 629540 2013 06 28 VIP Seafood Inc. 643809 N.B. INC. 643809 2013 07 03 Pedersen Video Inc. PedersenMedia Inc. 651131 2013 06 28 651527 N.B. Inc. CDC Robichaud Residences Inc. 651527 2013 07 02 Molex Canada Ltd. Woodhead Canada Limited/ Woodhead Canada Ltee 671138 2013 07 01 Act, a certificate of amalgamation has been issued to: un certificat de fusion a été émis à : Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour John D. Stevens Insurance (2013) Woodhead Canada Limited/ Woodhead Canada Limitée Miramichi Subway Inc. HENNESSEY CONSULTANTS INC. The Learning Bar Inc. STEVENS INSURANCE BROKERAGE INC. LOCKERBIE INSURANCE LTD. JOHN D. STEVENS INSURANCE LTD. H. WILSON INSURANCE LTD. MOLEX ELECTRONICS LIMITED Woodhead Canada Limited/ Woodhead Canada Limitée 619227 NB INC. Miramichi Subway Inc. G P C Consultants Inc. Hennessey Consultants Inc. The Learning Bar Inc. 647788 N.B. Inc. 647785 N.B. Inc. Miramichi 671044 2013 07 01 671138 2013 07 01 Tide Head 671168 2013 07 01 Moncton 671187 2013 07 01 671206 2013 07 01
The Royal Gazette July 24, 2013 1034 Gazette royale 24 juillet 2013 Saunders Equipment Ltd. CACHAL PROPERTY INVESTMENTS INC. SAUNDERS EQUIPMENT LTD. ACACIA HOLDINGS INC. Cachal Property Investments Inc. PPP PROPERTY DEVELOPMENT INC. 671207 2013 07 01 Rothesay 671209 2013 06 28 Act, a certificate of dissolution has been issued to: un certificat de dissolution a été émis à : Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour BLACKSTONE SERVICES LTD. 039763 2013 06 27 501479 NB Ltd. Moncton 501479 2013 06 28 LB Machinery Fabricator Ltd. Rogersville Ouest / West 601886 2013 06 28 Dr. Sara Hunter Professional Corporation Rothesay 611139 2013 06 27 645147 N.B. LTD. Bathurst 645147 2013 06 28 Ossett Holdings Limited 655115 2013 06 28 FUNCTION FIRST REHABILITATION INC. Quispamsis 658812 2013 06 30 Diamond Es En Czech Independent Living Services Ltd. Haute-Aboujagane 665740 2013 06 27 Act, a certificate of revival has been issued to: un certificat de reconstitution a été émis à : Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour Aleris Holding Canada Limited 625569 2013 07 02 Dr. Irina Turchin P.C. Inc. 645432 2013 07 02 Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation has been issued to: un certificat d enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour Penguin Canada Books Inc. Colombie-Britannique / British Columbia Stewart McKelvey Services 671137 2013 06 26 8479518 Canada Ltée Canada Yves Rondeau Bertrand 671256 2013 07 04
The Royal Gazette July 24, 2013 1035 Gazette royale 24 juillet 2013 Act, a certificate of amendment of registration of extraprovincial corporation has been issued to: un certificat de modification de l enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Previous name Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour TRANSAMERICA SECURITIES INC. VALEURS MOBILIÈRES TRANSAMERICA INC. WFG SECURITIES OF CANADA INC./ WFG VALEURS MOBILIERES DU CANADA INC. 077368 2013 07 01 PIONEER FUELS INC. PYE BROS. FUELS LTD. 668255 2013 07 02 Act, the Director has made a decision to cancel the registration of the following extra-provincial corporations: le Directeur a décidé d annuler l enregistrement des corporations extraprovinciales suivantes : Proposed Cancellation Notice / de de l avis l annulation projetée Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour CHEVRON LUBRICANTS CANADA INC. Canada Peter Klohn 074626 2013 07 02 2013 09 29 MERRILL LYNCH CAPITAL CANADA INC. Ontario Stewart McKelvey 076421 2013 07 02 2013 09 29 SilverBirch No. 36 Holdings Ltd. Canada Rodney D. Gould 076427 2013 07 02 2013 09 29 MEMBERWORKS CANADA TRAVEL SERVICES INC./ SERVICES DE VOYAGE MEMBERWORKS CANADA INC. GMAC RESIDENTIAL FUNDING OF CANADA, LIMITED/ FINANCEMENT RESIDENTIEL GMAC DU CANADA LIMITEE Québec / Quebec C. Paul W. Smith 077361 2013 07 02 2013 09 29 Canada C. Paul W. Smith 604831 2013 07 02 2013 09 29 CANADA MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORATION Ontario Stewart McKelvey 613404 2013 07 02 2013 09 29 INUKSHUK WIRELESS INC. INUKSHUK SANS FILS INC. Canada Stewart McKelvey 625132 2013 07 02 2013 09 29 GLUSKIN SHEFF MANAGEMENT CORPORATION Ontario Stewart McKelvey 625339 2013 07 02 2013 09 29 NBC ALTERNATIVE INVESTMENTS INC./BNC GESTION ALTERNATIVE INC. Canada Stewart McKelvey 632712 2013 07 02 2013 09 29 Qwest Energy Financial Corp. Canada Stewart McKelvey Tourmaline Partners, LLC Connecticut Stewart McKelvey 642922 2013 07 02 2013 09 29 654795 2013 07 02 2013 09 29
The Royal Gazette July 24, 2013 1036 Gazette royale 24 juillet 2013 Inmet Mining Corporation Canada Stewart McKelvey 656566 2013 07 02 2013 09 29 Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. Delaware Stewart McKelvey 666866 2013 07 02 2013 09 29 PUBLIC NOTICE is hereby given, under the Business Corporations Act, of the cancellation of the registration of the following extraprovincial corporations: un avis d annulation a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour WELLA CANADA, INC. Canada C. Paul W. Smith BOMBARDIER INC. Québec / Quebec Stewart McKelvey Services BALLAST NEDAM CANADA LIMITED Alberta Stewart McKelvey Services UNION SECURITIES LTD Canada George L. Cooper Moncton 072770 2013 07 02 076140 2013 07 02 076194 2013 07 02 077849 2013 07 02 Chemtrade Performance Chemicals Canada Inc./ Produits Chimiques Performance Chemtrade Canada Inc. Colombie-Britannique / British Columbia C. Paul W. Smith 606298 2013 07 02 Strategic Analysis (1994) Corporation Canada Stewart McKelvey Services MyNext Funding Corporation Canada Edward W. Keyes ECP GP II INC. Canada Stewart McKelvey Services ArcelorMittal Montréal Inc. Canada Stewart McKelvey Services ACCRETIVE 360 INC. Canada Stewart McKelvey Services WINDSTAR EQUITIES LTD. Ontario Stewart McKelvey Services 623088 2013 07 02 629766 2013 07 02 642098 2013 07 02 643665 2013 07 02 657503 2013 07 02 662157 2013 07 02
The Royal Gazette July 24, 2013 1037 Gazette royale 24 juillet 2013 TRADER CORPORATION/ SOCIÉTÉ TRADER CORPORATION Canada Steven Christie 662597 2013 07 02 Act, a certificate of registration of amalgamated corporation has been issued to the following extra-provincial corporations: un certificat d enregistrement d une corporation extraprovinciale issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Agent and Address Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour ABB INC. ABB INC. Walter Vail 671127 2013 06 25 Partnerships and Business Names Registration Act PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of business name has been registered: Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Certificate or Agent Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour GRTOZERPHOTO Gary Tozer Miramichi 670957 2013 07 01 Bold Investigation & Protection Daniel Larocque Dieppe 671082 2013 07 01 Halloween Party Centre 8347956 CANADA INC. 671101 2013 07 01 L.A. Réno-Pro Acadie 670804 NB Inc. Dugas Office 671141 2013 06 26 GOUTTIERES EXTREM OUTTIERES Yves Gionet Caraquet 671147 2013 07 01 Canadian Reports CANADA-REPORTS, ULC 671159 2013 06 27 Adam & Sons Plumbing and Heating Adam Glendenning Hillsborough 671161 2013 06 27 Wee College Peace Centre Five Saints Services Inc. Moncton 671166 2013 07 01 Eighteen fifty four The Maple Grove Inn Jeffrey Schnare Riverside Albert 671167 2013 06 27 GWB BUSINESS SOLUTIONS 650474 NB Inc. Miramichi 671173 2013 06 27 MILES GROUP OF COMPANIES CITY CONCRETE LTD. Hanwell 671178 2013 06 27 CamSpec Home Inspections Bayne Campbell Moncton 671183 2013 06 28 Granite Concepts WILDWOOD CABINETS LTD Moncton 671188 2013 06 28 J.Keys Consulting Josh Keys Keswick Ridge 671189 2013 06 28 Korry s Absolute Cleaning Entreprises Korry Tardif Inc. Saint-Léonard-Parent 671192 2013 06 28 Eastcoast Plumbing John Scharnberg Moncton 671196 2013 06 28
The Royal Gazette July 24, 2013 1038 Gazette royale 24 juillet 2013 Paul Hartinger Consulting Paul Hartinger Oromocto 671197 2013 06 28 SprinkWorks Design Scott Bulman Riverview 671202 2013 07 01 Dab Design Mark Dabarno Riverview 671205 2013 07 02 Computer Dan Daniel Frenette Chipman 671212 2013 07 02 Sussex Barbaer Shop Juanette Stronge Sussex Corner 671215 2013 07 02 Gitpo Tobacco & Gas Rebecca Knockwood Cherry Burton 671217 2013 07 02 The Gypsy s Attic Tammy Price Williamsburg 671221 2013 07 02 Colwell Janitorial Joann Colwell Moncton 671232 2013 07 02 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business name has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Certificate or Agent Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour SAMEDAY RIGHT-O-WAY COURIER DAY & ROSS INC. Hartland 331622 2013 07 04 Tom E. Leitch Consultant Thomas E. Leitch 344467 2013 07 02 The Auction Barn The Auction Center CAMERON AUCTIONEERS & APPRAISERS LTD. CAMERON AUCTIONEERS & APPRAISERS LTD. Taymouth 345504 2013 07 03 Taymouth 345505 2013 07 03 IRON-HEAD CYCLE & SLED SHOP Marco H. Page DSL de Saint-André / LSD of Saint-André 606389 2013 06 27 IMAGINE INSURANCE Imagine Financial Ltd. 607399 2013 06 27 URS URS CANADA INC. 607552 2013 06 28 URS CANADA URS CANADA INC. 607553 2013 06 28 CIBC IMPERIAL SERVICE CIBC Securities Inc. Placements CIBC Inc. 610126 2013 07 04 Tantramar Veterans Memorial Civic Centre Town of Sackville Sackville 631994 2013 06 28 King s Ice Cream Sarah Campbell Moncton 637914 2013 06 27 D AND A DISTRIBUTORS David Hatfield 637973 2013 06 28 Tae Kwon Do Dieppe Léon Richard Dieppe 638199 2013 07 02 AZ Design and Consultation Azadeh Joulaie Sackville 638223 2013 06 27 Jolly Good Cleaning Service Yvonne Jolly Moncton 638230 2013 06 28 Bombay The Bombay Company BOMBAY & CO. INC BOMBAY & CIE INC. BOMBAY & CO. INC BOMBAY & CIE INC. 638267 2013 07 04 638268 2013 07 04 Taylor & Rigby Communications Lieff Salonius Nashwaak Bridge 638799 2013 07 04
The Royal Gazette July 24, 2013 1039 Gazette royale 24 juillet 2013 FirstOnSite Restoration FirstOnSite Restoration L.P. 639618 2013 07 02 Ezi-Way FirstOnSite Restoration L.P. 639682 2013 07 02 Ezi-Way Cleaning Service FirstOnSite Restoration L.P. 639683 2013 07 02 Ezi-Way Disaster Kleenup FirstOnSite Restoration L.P. 639684 2013 07 02 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l activité ou de cessation d emploi de l appellation commerciale a été enregistré : Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour Kevin A. Morrison Transport Deerville 612527 2013 06 30 The Maple Grove Inn 1854 Riverside Albert 651514 2013 06 27 VIP Seafood Shediac 651982 2013 07 03 Granite Concepts Irishtown 652585 2013 06 28 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for service has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d un représentant pour fin de signification a été déposé : Agent and Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Représentant et adresse référence année mois jour SHELL CANADA PRODUCTS/ PRODUITS SHELL CANADA Shell Global Solutions Canada SHELL CANADA ENERGY Steven Christie Steven Christie Steven Christie 350821 2013 07 03 625094 2013 07 03 629285 2013 07 03 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour WADDY FORESTRY R.J. Waddy Ltd. Lands End Limited Colpitts Settlement 605514 2013 06 27
The Royal Gazette July 24, 2013 1040 Gazette royale 24 juillet 2013 BRADBURY & PAUL ENTERPRISES Harry Neil Bradbury Bradley Paul Florenceville-Bristol 638174 2013 06 27 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of partnership has been registered: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur l enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de dissolution de société en nom collectif a été enregistré : Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour GE EQUIPMENT SERVICES CANADA/ GE SERVICES D ÉQUIPEMENT CANADA Mississauga 622624 2013 06 28 GE CANADA VEHICLE & EQUIPMENT SERVICES/ 629209 2013 06 28 GE CANADA SERVICES DE LOCATION DE VÉHICULES ET D ÉQUIPEMENT Limited Partnership Act Loi sur les sociétés en commandite PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of limited partnership has been filed by: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite a été déposée par : Principal place in New Brunswick General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour ICO BRANDS L.P./ ICO MARQUES S.E.C. 8560854 Canada Inc 671130 2013 06 25 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has been filed: SACHEZ qu en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite extraprovinciale a été déposée par : Principal place in New Brunswick Agent and Address Principal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour Choice Properties Limited Partnership Ontario Walter Vail 671128 2013 06 25
The Royal Gazette July 24, 2013 1041 Gazette royale 24 juillet 2013 Notices of Sale STEPHEN MICHAEL STEEVES, of 6852 Route 112, at Canaan Forks, in the County of Queens and Province of New Brunswick, Mortgagor and owner of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first and second Mortgages; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 6852 Route 112, at Canaan Forks, in the County of Queens and Province of New Brunswick known as PID 45002060. Notice of sale is given by the holder of the said first and second Mortgages. Sale to be held on August 8 th, 2013, at 11:30 a.m., at the offices of the Village of Chipman located at 10 Civic Court, Unit 1, in Chipman, in the County of Queens and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper The Daily Gleaner editions of July 10 th, July 17 th, July 24 th and July 31 st, 2013. d at Edmundston, New Brunswick, this 27 th day of June, 2013. GARY J. McLAUGHLIN, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation ESTATE OF LÉONIDE LEBEL / ESTATE OF JOSEPH- LÉONIDE LEBEL, Mortgagor and owner of the land having the civic address of 377 Devost Road, in Sainte-Anne-de- Madawaska, in the County of Madawaska and Province of New Brunswick; CAISSE POPULAIRE MADAWASKA LTÉE, First Mortgagee; AND TO ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Property located at 377 Devost Road, in Sainte-Anne-de- Madawaska, in the County of Madawaska and Province of New Brunswick and identified by PID 35086107. Notice of sale given by the above holder of the first mortgage. Sale on August 7, 2013 at 11:00 a.m., at Carrefour Assomption, 121 Church Street, Edmundston, New Brunswick. See advertisement in the July 13, 20, 27, and August 3, 2013 editions of the weekly Le Madawaska. DATED at Edmundston, New Brunswick, this 5 th day of July, 2013 Gary J. McLaughlin, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solicitors and Agents for Caisse populaire Madawaska Ltée Avis de vente STEPHEN MICHAEL STEEVES, du 6852, route 112, Canaan Forks, comté de Queens, province du Nouveau- Brunswick, débiteur hypothécaire et propriétaire du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire des première et deuxième hypothèques; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 6852, route 112, Canaan Forks, comté de Queens, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 45002060. Avis de vente donné par la titulaire desdites première et deuxième hypothèques. La vente aura lieu le 8 août 2013, à 11 h 30, au bureau municipal du village de Chipman situé au 10, cour Civic, unité 1, Chipman, comté de Queens, province du Nouveau-Brunswick. Voir l annonce publiée dans les éditions des 10, 17, 24 et 31 juillet 2013 du journal The Daily Gleaner. Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 27 juin 2013. GARY J. McLAUGHLIN, c.r., Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada Est SUCCESSION LÉONIDE LEBEL / SUCCESSION JOSEPH LÉONIDE LEBEL, débiteur hypothécaire et propriétaire du bien-fonds ayant l adresse civique 377, chemin Devost, à Sainte-Anne-de-Madawaska, dans le comté de Madawaska et province du Nouveau-Brunswick; CAISSE PO- PULAIRE MADAWASKA LTÉE, à titre de créancière hypothécaire d une hypothèque de premier rang; et À TOUS AUTRES INTÉRESSÉS ÉVENTUELS. Propriété située au 377, chemin Devost, à Sainte-Anne-de- Madawaska, dans le comté de Madawaska et province du Nouveau-Brunswick et identifiée par le NID 35086107. Avis de vente donné par le titulaire susnommé de la première hypothèque. Vente le 7 août 2013 à 11 h de l avant-midi au Carrefour Assomption situé au 121, rue de l Église, à Edmundston (N.-B.). Voir l annonce parue dans le journal hebdomadaire Le Madawaska, éditions des 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet et 3 août 2013. FAIT à Edmundston (Nouveau-Brunswick), le 5 e jour de juillet 2013. Gary J. McLaughlin, c.r., Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et agents pour Caisse populaire Madawaska Ltée
The Royal Gazette July 24, 2013 1042 Gazette royale 24 juillet 2013 TO: TRACY LYNNE GORHAM, also known as TRACY LYNNE JONES, Mortgagor; AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.p-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 3827 Route 102 Highway, Island View, York County, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier 75050781. Notice of Sale is given by TD Financing Services Home Inc. The sale is scheduled for Thursday, August 15, 2013, at 11:00 a.m., at the Court House, 427 Queen Street,, New Brunswick. See advertisements in The Daily Gleaner in the issues of July 17, July 24, July 31 and August 7, 2013. TD Financing Services Home Inc., By: LAWSON CREAMER, Per: Robert M. Creamer, Solicitors for TD Financing Services Home Inc. DESTINATAIRES : TRACY LYNNE GORHAM, également connue sous le nom de TRACY LYNNE JONES, débitrice hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.p-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 3827, route 102, Island View, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d identification parcellaire est 75050781. Avis de vente donné par Services de financement TD résidentiel Inc. La vente aura lieu le jeudi 15 août 2013, à 11 h, au palais de justice de, 427, rue Queen, (Nouveau- Brunswick). Voir l annonce publiée dans les éditions des 17, 24 et 31 juillet et du 7 août 2013 du journal The Daily Gleaner. Robert M. Creamer, du cabinet LAWSON & CREAMER, avocats de Services de financement TD résidentiel Inc. Notice to Advertisers The Royal Gazette is published every Wednesday under the authority of the Queen s Printer Act. Documents must be received by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen s Printer Office, no later than noon, at least seven days prior to Wednesday s publication. Each document must be separate from the covering letter. Signatures on documents must be immediately followed by the printed name. The Queen s Printer may refuse to publish a document if any part of it is illegible, and may delay publication of any document for administrative reasons. Prepayment is required for the publication of all documents. Standard documents have the following set fees: Avis aux annonceurs La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à la Loi sur l Imprimeur de la Reine. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, au bureau de l Imprimeur de la Reine, à midi, au moins sept jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé de la lettre d envoi. Les noms des signataires doivent suivre immédiatement la signature. L Imprimeur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une partie est illisible et retarder la publication d un avis pour des raisons administratives. Le paiement d avance est exigé pour la publication des avis. Voici les tarifs pour les avis courants : Notices Cost per Insertion Avis Coût par parution Notice of the intention to apply for the enactment of a $ 20 private bill Originating process $ 25 Order of a court $ 25 Notice under the Absconding Debtors Act $ 20 Notice under the General Rules under the Law Society Act, $ 20 1996, of disbarment or suspension or of application for reinstatement or readmission Notice of examination under the Licensed Practical Nurses $ 25 Act Notice under the Motor Carrier Act $ 30 Any document under the Political Process Financing Act $ 20 Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 under the Probate Court Act Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B) Note: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14 Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is 1 /2 page in length or less $ 20 $120 $ 20 Avis d intention de demander l adoption d un projet de loi 20 $ d intérêt privé Acte introductif d instance 25 $ Ordonnance rendue par une cour 25 $ Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $ Avis de radiation ou de suspension ou de demande de 20 $ réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Avis d examen exigé par la Loi sur les infirmières et 25 $ infirmiers auxiliaires autorisés Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $ Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le 20 $ financement de l activité politique Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau- 20 $ Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété 120 $ (Formule 70B) Nota : Les plans d arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie 20 $ d annonces, si l avis est d une demi-page ou moins en longueur
The Royal Gazette July 24, 2013 1043 Gazette royale 24 juillet 2013 Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is greater than 1 /2 page in length Any document under the Winding-up and Restructuring Act (Canada) Notice of a correction Any other document $ 75 $ 20 charge is the same as for publishing the original document $3.50 for each cm or less Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d annonces, si l avis est de plus d une demi-page en longueur Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) Avis d une correction Tout autre document 75 $ 20 $ les frais sont les mêmes que ceux imposés pour la publication du document original 3,50 $ pour chaque cm ou moins Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or money order (payable to the Minister of Finance). No refunds will be issued for cancellations. The official version of The Royal Gazette is available free on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the printed annual subscription service. The Royal Gazette can be accessed on-line at: http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ attorney_general/royal_gazette.html Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at the Office of the Queen s Printer, at $4.00 per copy plus 13% tax, plus shipping and handling where applicable. Office of the Queen s Printer 670 King Street, Room 117 P.O. Box 6000, NB E3B 5H1 Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899 E-mail: gazette@gnb.ca Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établi à l ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d annulation. La version officielle de la Gazette royale est disponible gratuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en ligne remplace le service d abonnement annuel. Vous trouverez la Gazette royale à l adresse suivante : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/ procureur_general/gazette_royale.html Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette royale, au bureau de l Imprimeur de la Reine, pour la somme de 4 $ l exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les frais applicables de port et de manutention. Bureau de l Imprimeur de la Reine 670, rue King, pièce 117 C.P. 6000 (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899 Courriel : gazette@gnb.ca QUEEN S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés